


Osage County Cousins
Genealogy for Banks - Parson - Kemple - Mantle - Monroe - Redden - Butler Families

Griffith Richard Pritchard

( = Descendancy chart to this point,
= Expand,
= Collapse)
- 1 Griffith Richard Pritchard [1] d. 1746
Mary _____ d. 1747
- 2 Elizabeth Pritchard [1.1]
b. 21 Feb 1720 d. 1 Jun 1755
Llewellyn Davis b. 21 Feb 1720 d. 12 Jul 1794
- 3 Isaac Davis [1.1.1]
b. 1775 d. 1842
Mary Elizabeth Kennedy b. 1770 d. Oct 1850
- 4 Nancy Davis [1.1.1.1]
b. 14 Jul 1795 d. 8 Aug 1853
Marcus Monroe b. 3 Aug 1793 d. 6 Sep 1870
- 5 Lea Anderson Monroe [1.1.1.1.1]
b. 13 May 1815 d. 1887
Nancy Atkins b. 4 Apr 1815 d. 14 Jun 1889
- 6 Mark M Monroe [1.1.1.1.1.1]
b. 28 May 1835 d. 19 Jan 1918
Lurette Adkins b. Abt 1835 d. Bef 1910
- 7 Anna Cordia Monroe [1.1.1.1.1.1.1]
b. 2 Dec 1854 d. 9 Jan 1932
- 7 Eldridge Monroe [1.1.1.1.1.1.2]
b. Abt 1857 d. 14 Apr 1950
Amelia Rucker b. 24 May 1857 d. 20 Jun 1936
- 8 Tolbert Prailo Monroe [1.1.1.1.1.1.2.1]
b. 11 Mar 1885 d. 9 May 1951
Lyda Grace Needham b. 18 May 1885 d. 26 Sep 1970
- 9 Weir Lee Monroe, Sr [1.1.1.1.1.1.2.1.1]
b. 28 Dec 1904 d. 4 Apr 1997
Estella Corrina Booker b. 20 Jun 1896 d. 31 Aug 1973
- 10 Frances V Monroe [1.1.1.1.1.1.2.1.1.1]
b. 31 Mar 1925 d. 8 Oct 1990
- + Charles Frederick Lattimore, III b. 5 Dec 1920 d. 15 Feb 2006
- + Charles Frederick Lattimore, III b. 5 Dec 1920 d. 15 Feb 2006
- 10 Weir Lee Monroe, Jr [1.1.1.1.1.1.2.1.1.2]
b. 15 Feb 1929 d. 22 Apr 1996
Bertha Irene Dennis b. 15 Oct 1930 d. 19 Oct 2001
- 11 L. Monroe [1.1.1.1.1.1.2.1.1.2.1]
- 11 L. Monroe [1.1.1.1.1.1.2.1.1.2.2]
- + D. Lane
- + D. Lane
- 11 T. Monroe [1.1.1.1.1.1.2.1.1.2.3]
- 11 K.J. Monroe [1.1.1.1.1.1.2.1.1.2.4]
Felix Roy (Phil) Hatmaker, Sr b. 3 Nov 1961 d. 28 Apr 2006
- 12 J. Hatmaker [1.1.1.1.1.1.2.1.1.2.4.1]
- 12 F.R. Hatmaker, Jr [1.1.1.1.1.1.2.1.1.2.4.2]
- 12 J. Hatmaker [1.1.1.1.1.1.2.1.1.2.4.1]
- 11 Tolbert Deane Monroe [1.1.1.1.1.1.2.1.1.2.5]
b. 7 Mar 1970 d. 21 Jul 2009
- 11 L. Monroe [1.1.1.1.1.1.2.1.1.2.1]
- 10 Morris Hall Monroe, Sr [1.1.1.1.1.1.2.1.1.3]
b. 7 May 1930 d. 13 Feb 1985
- 10 Frances V Monroe [1.1.1.1.1.1.2.1.1.1]
- 9 Calma Vaughn Monroe [1.1.1.1.1.1.2.1.2]
b. 2 May 1916 d. 19 Aug 1999
Hazel C Vandergriff b. 11 Jun 1917 d. 21 Jul 1963
- 10 Harl Lee Monroe [1.1.1.1.1.1.2.1.2.1]
b. 6 Jun 1939 d. 5 Mar 2015
- 10 L. Monroe [1.1.1.1.1.1.2.1.2.2]
- 10 Brenda Faye Monroe [1.1.1.1.1.1.2.1.2.3]
b. 7 Feb 1950 d. 3 Jun 2014
- 10 Harl Lee Monroe [1.1.1.1.1.1.2.1.2.1]
- + Sara Elizabeth Clement b. 1 Nov 1918 d. 20 Sep 1998
- 9 Frances Maud Monroe [1.1.1.1.1.1.2.1.3]
b. 25 Nov 1918 d. 10 Sep 1922
- 9 Edna Lucile Monroe [1.1.1.1.1.1.2.1.4]
b. 4 May 1921 d. 2 Feb 2015
- + Pryor Lee Acuff b. 5 Mar 1908 d. 19 Jan 1998
- + Pryor Lee Acuff b. 5 Mar 1908 d. 19 Jan 1998
- 9 Weir Lee Monroe, Sr [1.1.1.1.1.1.2.1.1]
- 8 Tolbert Prailo Monroe [1.1.1.1.1.1.2.1]
- 7 Anna Cordia Monroe [1.1.1.1.1.1.1]
Sarah Harrison b. Abt 1850 d. 16 Sep 1882
- 7 Arlee G Monroe [1.1.1.1.1.1.3]
b. Apr 1867 d. 1947
- 7 Vilance Monroe [1.1.1.1.1.1.4]
b. 1874
- 7 Mary Etta Monroe [1.1.1.1.1.1.5]
b. 30 May 1874
- 7 Matilda Roberta Monroe [1.1.1.1.1.1.6]
b. Nov 1879 d. 25 Nov 1968
- 7 Arlee G Monroe [1.1.1.1.1.1.3]
Nancy E Dyer b. 2 Oct 1849 d. 10 Mar 1889
- 7 Amanda Tennessee Monroe [1.1.1.1.1.1.7]
b. 11 Oct 1884 d. 21 Jan 1891
- 7 Amanda Tennessee Monroe [1.1.1.1.1.1.7]
Emily Jones b. Abt 1860 d. 5 Jul 1920
- 7 Horace Leonard Monroe [1.1.1.1.1.1.8]
b. 5 Jun 1890 d. Sep 1970
- 7 Horace Leonard Monroe [1.1.1.1.1.1.8]
- 6 Margaret Monroe [1.1.1.1.1.2]
b. 1838 d. 11 Aug 1904
- 6 Martin V Monroe [1.1.1.1.1.3]
b. Aug 1838 d. 24 Oct 1914
- 6 Louisa Jane Monroe [1.1.1.1.1.4]
b. 17 Jun 1839 d. 18 Aug 1913
Thomas Brooks McMillin b. 19 Jul 1834 d. 7 Dec 1864
- 7 James Morgan McMillin [1.1.1.1.1.4.1]
b. 1 Jul 1859 d. 31 Aug 1934
Mary Frances Leslie b. 9 Feb 1862 d. 19 Nov 1920
- 8 Oscar Oren McMillin [1.1.1.1.1.4.1.1]
b. 16 May 1884 d. 9 Mar 1942
Elva May Roark b. 1 May 1884 d. 14 Mar 1979
- 9 Infant McMillin [1.1.1.1.1.4.1.1.1]
b. 22 Aug 1910 d. 22 Aug 1910
- 9 Leslie Oren McMillin [1.1.1.1.1.4.1.1.2]
b. 12 Dec 1918 d. 28 May 1988
Dorothy Louise Feasel b. 5 Nov 1922 d. 13 Nov 1992
- 10 D.L. McMillin [1.1.1.1.1.4.1.1.2.1]
- 10 Leslie Anne McMillin [1.1.1.1.1.4.1.1.2.2]
b. 4 Feb 1946 d. 3 Feb 2004
- 10 D.L. McMillin [1.1.1.1.1.4.1.1.2.1]
- 9 Infant McMillin [1.1.1.1.1.4.1.1.1]
- 8 Ethel Grace McMillin [1.1.1.1.1.4.1.2]
b. 23 Jan 1888 d. 18 May 1911
- 8 Lester Brooks McMillin [1.1.1.1.1.4.1.3]
b. 19 Sep 1890 d. 2 Nov 1977
- 8 John Leslie McMillin [1.1.1.1.1.4.1.4]
b. 3 May 1894 d. 4 Dec 1931
Bessie Olive McDonald b. 14 Oct 1890 d. 29 Sep 1977
- 9 Charles Herbert McMillin [1.1.1.1.1.4.1.4.1]
b. 12 May 1927 d. 26 Feb 1994
- 9 Charles Herbert McMillin [1.1.1.1.1.4.1.4.1]
- 8 Alice Rella McMillin [1.1.1.1.1.4.1.5]
b. 14 Apr 1896 d. 28 May 1984
- 8 Virgie Fonso McMillin [1.1.1.1.1.4.1.6]
b. 20 Apr 1898 d. 10 Jan 1936
Levi Edward Saylor b. 4 Nov 1904 d. 23 Jul 1984
- 9 Frances Katherine Saylor [1.1.1.1.1.4.1.6.1]
b. 24 Jan 1933 d. 20 Apr 1962
David Edward Hauf, Sr b. 11 Dec 1928 d. 30 Apr 1962
- 10 Debra Dianne Hauf [1.1.1.1.1.4.1.6.1.1]
b. 6 Dec 1951 d. 20 Apr 1962
- 10 David Edward Hauf, Jr [1.1.1.1.1.4.1.6.1.2]
b. 20 Aug 1959 d. 20 Apr 1962
- 10 Debra Dianne Hauf [1.1.1.1.1.4.1.6.1.1]
- 9 Virgil Lee Saylor [1.1.1.1.1.4.1.6.2]
b. 2 Jan 1936 d. 14 Feb 1936
- 9 Frances Katherine Saylor [1.1.1.1.1.4.1.6.1]
- 8 Charles B McMillin [1.1.1.1.1.4.1.7]
b. 17 Mar 1900 d. 21 Jul 1902
- 8 Floyd Elza McMillin [1.1.1.1.1.4.1.8]
b. 28 Jun 1902 d. 10 Jul 1968
- + Ruth Mildred Long b. 25 Mar 1905 d. 11 Dec 2001
- + Ruth Mildred Long b. 25 Mar 1905 d. 11 Dec 2001
- 8 Audrey Lorene McMillin [1.1.1.1.1.4.1.9]
b. 13 Sep 1905 d. 4 Sep 1979
- + Carlos Russell Ellis b. 20 Sep 1900 d. 19 Apr 1992
- + Carlos Russell Ellis b. 20 Sep 1900 d. 19 Apr 1992
- 8 Oscar Oren McMillin [1.1.1.1.1.4.1.1]
- 7 Infant McMillin [1.1.1.1.1.4.2]
b. 3 Mar 1863 d. 22 Feb 1864
- 7 James Morgan McMillin [1.1.1.1.1.4.1]
Noah Roark b. 13 Jun 1832 d. 11 Mar 1898
- 7 Rella Randolph Roark [1.1.1.1.1.4.3]
b. 5 Dec 1867 d. 15 Nov 1966
Daniel Webster Son b. 1 Jan 1865 d. 9 Jul 1955
- 8 Alma Jane (Munna) Son [1.1.1.1.1.4.3.1]
b. 28 Mar 1891 d. 2 Feb 1983
Francis Moore (Mode) Milburn b. 25 May 1883 d. 1 Jan 1975
- 9 Daniel Judson Milburn [1.1.1.1.1.4.3.1.1]
b. 17 Feb 1913 d. 26 Aug 2000
Vera Pritchard b. Abt 1917
- 10 M.K. Milburn [1.1.1.1.1.4.3.1.1.1]
- 10 I.M. Milburn [1.1.1.1.1.4.3.1.1.2]
- 10 M.K. Milburn [1.1.1.1.1.4.3.1.1.1]
- 9 Donald Wyeth Milburn [1.1.1.1.1.4.3.1.2]
b. 7 Sep 1914 d. 20 May 2000
Mary Elizabeth Myers b. Abt 1916
- 10 R.L. Melburn [1.1.1.1.1.4.3.1.2.1]
- 10 M. Melburn [1.1.1.1.1.4.3.1.2.2]
- 10 J. Melburn [1.1.1.1.1.4.3.1.2.3]
- 10 R.L. Melburn [1.1.1.1.1.4.3.1.2.1]
- 9 Nell Milburn [1.1.1.1.1.4.3.1.3]
b. 16 Apr 1916 d. 19 Nov 2005
- 9 Eloise M Milburn [1.1.1.1.1.4.3.1.4]
b. 21 Jul 1918 d. 21 Jun 2008
William Ramsey Harris b. 28 Jun 1915 d. 21 Jan 2008
- 10 K.H. Harris [1.1.1.1.1.4.3.1.4.1]
- 10 W.R. Harris, Jr [1.1.1.1.1.4.3.1.4.2]
- 10 D.M. Harris [1.1.1.1.1.4.3.1.4.3]
- 10 K.H. Harris [1.1.1.1.1.4.3.1.4.1]
- 9 June M Milburn [1.1.1.1.1.4.3.1.5]
b. 16 Jun 1920 d. 7 Jun 2019
Sigfrid Emanuel Floren, Jr b. 3 Jul 1919 d. 20 Jan 1980
- 10 C.M. Floren [1.1.1.1.1.4.3.1.5.1]
- 10 C.M. Floren [1.1.1.1.1.4.3.1.5.1]
- 9 Mode Wayne Milburn [1.1.1.1.1.4.3.1.6]
b. 15 Apr 1922 d. 19 Jun 1982
- 9 Daniel Judson Milburn [1.1.1.1.1.4.3.1.1]
- 8 Ruth Son [1.1.1.1.1.4.3.2]
b. 16 Sep 1892 d. 26 Jun 1984
Elbert Paul Powell b. 8 Mar 1883 d. 1952
- 9 Paul Thurston Powell [1.1.1.1.1.4.3.2.1]
b. 9 Dec 1914 d. 1 Jul 1988
Lucille Elaine Hinshaw b. 17 Aug 1917 d. 22 Feb 1993
- 10 P. Powell [1.1.1.1.1.4.3.2.1.1]
- 10 Paul Hinshaw Powell [1.1.1.1.1.4.3.2.1.2]
b. 2 Sep 1945 d. 25 Mar 2013
- 10 Phillip Raymond Powell [1.1.1.1.1.4.3.2.1.3]
b. 24 Jun 1948 d. 19 Nov 2020
- 10 P. Powell [1.1.1.1.1.4.3.2.1.1]
- 9 Glenn Dorris Powell [1.1.1.1.1.4.3.2.2]
b. Abt 1917
- 9 Paul Thurston Powell [1.1.1.1.1.4.3.2.1]
- 8 Daniel Randolph (Dolph) Son [1.1.1.1.1.4.3.3]
b. 6 May 1894 d. 21 Oct 1969
Sally Belinda O'Dell b. Abt 1899
- 9 James Daniel Son [1.1.1.1.1.4.3.3.1]
b. 2 Mar 1916 d. 6 Jun 1985
- 9 Geraldine J Son [1.1.1.1.1.4.3.3.2]
b. 10 Apr 1918 d. 4 Feb 2005
Glen Alvin Triplitt b. 8 Sep 1915 d. 28 Jul 1993
- 10 Daniel Glenn Triplitt [1.1.1.1.1.4.3.3.2.1]
b. 5 Aug 1939 d. 4 May 1970
- 10 Daniel Glenn Triplitt [1.1.1.1.1.4.3.3.2.1]
- 9 James Daniel Son [1.1.1.1.1.4.3.3.1]
- + Alice Lindell Peacock b. Abt 1899 d. 7 Feb 1970
- 8 Ireta Son [1.1.1.1.1.4.3.4]
b. 9 Feb 1896 d. 1 Feb 1983
Arthur Clifton Jacks b. 29 Aug 1893 d. 21 May 1968
- 9 Rella Anne Jacks [1.1.1.1.1.4.3.4.1]
b. 30 Apr 1922 d. 29 Mar 2018
- 9 Dorothy Jane Jacks [1.1.1.1.1.4.3.4.2]
b. Abt 1924 d. 20 Nov 2015
- 9 Lajoy Jacks [1.1.1.1.1.4.3.4.3]
b. 29 Aug 1927 d. 10 Mar 1989
- 9 Rella Anne Jacks [1.1.1.1.1.4.3.4.1]
- + Carl Clifford Creamer b. 29 Jul 1896 d. 10 Sep 1956
- 8 Noah Malcolm Son [1.1.1.1.1.4.3.5]
b. 24 Nov 1897 d. 30 Jul 1990
Emma Milburn b. 3 Oct 1897 d. 20 Jul 1968
- 9 Noah Dean Son [1.1.1.1.1.4.3.5.1]
b. 7 Jul 1920 d. 23 Feb 1996
- 9 Neysa Son [1.1.1.1.1.4.3.5.2]
b. 1 Jun 1923 d. 12 Feb 2017
N. Shires
- 10 M. Shires [1.1.1.1.1.4.3.5.2.1]
- 10 M. Shires [1.1.1.1.1.4.3.5.2.1]
- + Luther Lee Lively b. 21 Sep 1917 d. 8 Jan 2009
David Neyland Compton
- 10 D.N. Compton, II [1.1.1.1.1.4.3.5.2.2]
- 10 D.N. Compton, II [1.1.1.1.1.4.3.5.2.2]
- 9 James Howell Son [1.1.1.1.1.4.3.5.3]
b. 28 May 1925 d. 7 Aug 2018
Verna Beth Eddins b. 27 Nov 1925 d. 26 Jul 2016
- 9 Sue Ellen Son [1.1.1.1.1.4.3.5.4]
b. 7 Aug 1927 d. 3 Sep 2019
- + William Byron Billman b. 5 Jan 1921 d. 1 Oct 2006
- + William Byron Billman b. 5 Jan 1921 d. 1 Oct 2006
- 9 Noah Dean Son [1.1.1.1.1.4.3.5.1]
- 8 Mountan Son [1.1.1.1.1.4.3.6]
b. Abt 1899
- 8 James Aubrey Son [1.1.1.1.1.4.3.7]
b. 24 Oct 1900 d. 17 Aug 1972
- + Carrie M Murrell b. 3 Mar 1900 d. 15 Jan 1974
- + Carrie M Murrell b. 3 Mar 1900 d. 15 Jan 1974
- 8 Orbra J Son [1.1.1.1.1.4.3.8]
b. Abt 1901 d. 17 Aug 1972
- 8 Bessica Son [1.1.1.1.1.4.3.9]
b. 24 Oct 1902 d. 4 Apr 1987
Perry Phillip Britten b. 18 Jan 1905 d. 4 Mar 1981
- 9 D. Britten [1.1.1.1.1.4.3.9.1]
- 9 J. Britten [1.1.1.1.1.4.3.9.2]
- 9 D. Britten [1.1.1.1.1.4.3.9.1]
- 8 John Webster Son [1.1.1.1.1.4.3.10]
b. 31 Mar 1906 d. 23 Nov 1987
- + Bertha Edna Clayton b. 29 Jan 1910 d. 23 Apr 2005
- + Bertha Edna Clayton b. 29 Jan 1910 d. 23 Apr 2005
- 8 Alma Jane (Munna) Son [1.1.1.1.1.4.3.1]
- 7 William Monroe Roark [1.1.1.1.1.4.4]
b. 17 Dec 1873 d. 12 Apr 1926
- 7 Rella Randolph Roark [1.1.1.1.1.4.3]
- 6 Mary Addie Monroe [1.1.1.1.1.5]
b. 1842 d. Between 1843 and 1936
- 6 James Calvin Monroe [1.1.1.1.1.6]
b. 21 Apr 1844 d. 9 Jan 1909
Mary Ann Shadwick b. 11 Feb 1853 d. 14 May 1947
- 7 Alfred Edwin Monroe, MD [1.1.1.1.1.6.1]
b. 10 Apr 1870 d. 30 Jun 1954
Sarah Frances Hill b. 11 Mar 1874 d. 3 May 1951
- 8 Edith Lucille Monroe [1.1.1.1.1.6.1.1]
b. 12 Nov 1897 d. 15 Nov 1961
William Dresel Cunningham b. 16 Oct 1898 d. 17 Sep 1983
- 9 Billy Jean Cunningham [1.1.1.1.1.6.1.1.1]
b. 25 Jul 1922 d. 14 Jun 2010
Paul Alvin Nesselroad b. 9 Aug 1921 d. 25 Aug 1973
- 10 P.E. Nesselroad [1.1.1.1.1.6.1.1.1.1]
- + J. Lewis
- + J. Lewis
- 10 P.K. Nesselroad [1.1.1.1.1.6.1.1.1.2]
- + Butcher
- + D.L. Ellis
- + Butcher
- 10 N.A. Nesselroad [1.1.1.1.1.6.1.1.1.3]
- 10 P.E. Nesselroad [1.1.1.1.1.6.1.1.1.1]
- + Donald John Vinson b. 29 Feb 1920 d. 5 Jan 2011
- 9 Billy Jean Cunningham [1.1.1.1.1.6.1.1.1]
- 8 Edith Lucille Monroe [1.1.1.1.1.6.1.1]
- 7 Nevada Elizabeth Monroe [1.1.1.1.1.6.2]
b. 5 Aug 1872 d. 1 Apr 1947
- + Lucian C Wilkerson b. 20 Apr 1871 d. 29 Mar 1957
- + Lucian C Wilkerson b. 20 Apr 1871 d. 29 Mar 1957
- 7 Mary Melcenia Monroe [1.1.1.1.1.6.3]
b. 27 Sep 1875 d. 16 Mar 1949
John Louis Morrow b. Feb 1867 d. 6 Jan 1930
- 8 Undrie Richard Morrow [1.1.1.1.1.6.3.1]
b. 30 Oct 1894 d. 4 May 1896
- 8 Hubert Orion Morrow [1.1.1.1.1.6.3.2]
b. 30 Jun 1898 d. 3 Nov 1978
Lula E Lurton b. 22 Mar 1898 d. 15 Feb 1989
- 9 Jack Morrow [1.1.1.1.1.6.3.2.1]
b. 26 Nov 1916 d. 22 Jul 2000
Jane Francis Kenney b. 7 Jan 1918 d. Jun 1994
- 10 M.J. Morrow [1.1.1.1.1.6.3.2.1.1]
- 10 K.H. Morrow [1.1.1.1.1.6.3.2.1.2]
- 10 M.J. Morrow [1.1.1.1.1.6.3.2.1.1]
- 9 Lois E Morrow [1.1.1.1.1.6.3.2.2]
b. 1 Apr 1920 d. 2 Sep 1933
- 9 Jack Morrow [1.1.1.1.1.6.3.2.1]
- 8 Undrie Richard Morrow [1.1.1.1.1.6.3.1]
Clark E Templeton b. 26 Feb 1862 d. 28 Mar 1937
- 8 Commodore Dewey Templeton [1.1.1.1.1.6.3.3]
b. 31 Jul 1899 d. 11 Mar 1967
- 8 Bessie Mae Templeton [1.1.1.1.1.6.3.4]
b. 28 Feb 1902 d. 10 Aug 1992
Roy Seldon Atwell b. 23 Apr 1900 d. 6 May 1971
- 9 Archie Harold Atwell [1.1.1.1.1.6.3.4.1]
b. 29 Apr 1920 d. 3 Aug 1976
- 9 James Howard Atwell [1.1.1.1.1.6.3.4.2]
b. 27 Jul 1926 d. 4 May 2014
Juanita Ellen Stephens b. 24 Apr 1930 d. 18 Sep 2012
- 9 Geraldine Atwell [1.1.1.1.1.6.3.4.3]
b. 13 Sep 1929 d. 19 Jun 2005
Charles Leslie Pendleton b. 22 May 1927 d. 1983
- 10 H.M. Pendleton [1.1.1.1.1.6.3.4.3.1]
- 10 D. Pendleton [1.1.1.1.1.6.3.4.3.2]
- + Ash
- + Ash
- 10 L. Pendleton [1.1.1.1.1.6.3.4.3.3]
- 10 Daniel Leslie Pendleton [1.1.1.1.1.6.3.4.3.4]
b. 4 Sep 1949 d. 24 Oct 2006
- 10 Helen Darlene Pendleton [1.1.1.1.1.6.3.4.3.5]
b. 9 Dec 1950 d. 17 Dec 2017
- 10 Lois Charlene Pendleton [1.1.1.1.1.6.3.4.3.6]
b. 30 Dec 1951 d. 12 Nov 2015
- 10 Kenneth Duane Pendleton [1.1.1.1.1.6.3.4.3.7]
b. 24 Jul 1953 d. 28 Apr 1963
- 10 Sandra Kay Pendleton [1.1.1.1.1.6.3.4.3.8]
b. 22 Oct 1954 d. 3 Nov 1968
- 10 Joyce Yvonne Pendleton [1.1.1.1.1.6.3.4.3.9]
b. 22 Dec 1955 d. 7 Dec 1973
- + Jessie E Lawson b. 16 May 1953 d. 7 Dec 1973
- + Jessie E Lawson b. 16 May 1953 d. 7 Dec 1973
- 10 Roger Dale Pendleton [1.1.1.1.1.6.3.4.3.10]
b. 21 Jul 1971 d. 31 Jul 1971
- 10 H.M. Pendleton [1.1.1.1.1.6.3.4.3.1]
- 9 Baby Boy Atwell [1.1.1.1.1.6.3.4.4]
b. 1938 d. 1938
- 9 Baby Boy Atwell [1.1.1.1.1.6.3.4.5]
b. 1939 d. 1939
- 9 Archie Harold Atwell [1.1.1.1.1.6.3.4.1]
- 8 Basell E Tempelton [1.1.1.1.1.6.3.5]
b. 19 Apr 1905 d. 7 Sep 1974
- 8 Marvin O Templeton [1.1.1.1.1.6.3.6]
b. 29 Apr 1906 d. 17 Apr 1974
- 8 Lawrence Raymond Templeton [1.1.1.1.1.6.3.7]
b. Abt 1910 d. UNKNOWN
- 8 Evelyn Bell Bernard [1.1.1.1.1.6.3.8]
b. 23 Aug 1912 d. 11 Nov 2001
- 8 Edmond Hoed Templeton [1.1.1.1.1.6.3.9]
b. 1 Dec 1917 d. Dec 1993
- 8 Ruby Pauline Templeton [1.1.1.1.1.6.3.10]
b. 30 Jun 1918 d. 11 Sep 1999
- + Carl Franklin Teer b. 22 Nov 1919 d. 28 Dec 1994
- + King
- + Carl Franklin Teer b. 22 Nov 1919 d. 28 Dec 1994
- 8 Commodore Dewey Templeton [1.1.1.1.1.6.3.3]
- 7 William Alfred Monroe [1.1.1.1.1.6.4]
b. 30 Nov 1877 d. 26 May 1878
- 7 George Calvin Monroe [1.1.1.1.1.6.5]
b. 23 Oct 1879 d. 15 Mar 1966
Cora Frances Thomas b. 10 May 1881 d. 18 Jun 1970
- 8 Infant Monroe [1.1.1.1.1.6.5.1]
b. 24 Dec 1907 d. 24 Dec 1907
- 8 George Calvin Monroe, Jr [1.1.1.1.1.6.5.2]
b. 9 Oct 1909 d. 29 Apr 1990
W.R. Culp
- 9 L.E. Monroe [1.1.1.1.1.6.5.2.1]
K.A. Brummett
- 10 S.A. Monroe [1.1.1.1.1.6.5.2.1.1]
- 10 J.E. Monroe [1.1.1.1.1.6.5.2.1.2]
- 10 S.A. Monroe [1.1.1.1.1.6.5.2.1.1]
- 9 G.T. Monroe [1.1.1.1.1.6.5.2.2]
- 9 L.E. Monroe [1.1.1.1.1.6.5.2.1]
- 8 John Thomas Monroe [1.1.1.1.1.6.5.3]
b. 4 Jan 1912 d. 16 Mar 1914
- 8 Edwin Ulys Monroe [1.1.1.1.1.6.5.4]
b. 25 Feb 1915 d. 20 Jan 1945
Doris Mae Driggers b. 11 Jul 1916 d. 31 Dec 2006
- 9 L.F. Monroe [1.1.1.1.1.6.5.4.1]
- + Burton
- + Burton
- 9 B.B. Monroe [1.1.1.1.1.6.5.4.2]
- + Hardy
- + Hardy
- 9 L.F. Monroe [1.1.1.1.1.6.5.4.1]
- 8 Infant Monroe [1.1.1.1.1.6.5.1]
- 7 Lillie Maude Monroe [1.1.1.1.1.6.6]
b. 16 Jul 1882 d. 15 Aug 1974
Thomas David Gregory b. 23 Feb 1878 d. 20 Feb 1963
- 8 Maynard Monroe Gregory [1.1.1.1.1.6.6.1]
b. 8 Dec 1900 d. 13 Mar 1909
- 8 Maurice T Gregory [1.1.1.1.1.6.6.2]
b. 29 Jul 1906 d. 29 Mar 1991
- 8 Maynard Monroe Gregory [1.1.1.1.1.6.6.1]
- 7 Ulysses Sidney Monroe, MD [1.1.1.1.1.6.7]
b. 14 Nov 1885 d. 15 Apr 1961
Edna Lee Howard b. 6 Sep 1885 d. 22 Sep 1976
- 8 Lance Truman Monroe, MD [1.1.1.1.1.6.7.1]
b. 6 May 1906 d. 7 Jun 1994
Edythe Mae Smith b. Abt 1914 d. 4 Jul 1972
- 9 M.A. Monroe [1.1.1.1.1.6.7.1.1]
- 9 N.L. Monroe [1.1.1.1.1.6.7.1.2]
- 9 L.T. Monroe [1.1.1.1.1.6.7.1.3]
- 9 K. Monroe [1.1.1.1.1.6.7.1.4]
- 9 E.A. Monroe [1.1.1.1.1.6.7.1.5]
- 9 M.A. Monroe [1.1.1.1.1.6.7.1.1]
- 8 Edna Geneva Monroe [1.1.1.1.1.6.7.2]
b. 12 Feb 1910 d. 17 Feb 2003
Benjamin Phillip Adams, Jr b. 10 Jan 1911 d. 15 Jun 1995
- 9 Edna Geraldine Adams [1.1.1.1.1.6.7.2.1]
b. 1 Sep 1940 d. 14 May 2005
- 9 B.P. Adams, III [1.1.1.1.1.6.7.2.2]
M. Ridenour
- 10 B.P. Adams, IV [1.1.1.1.1.6.7.2.2.1]
- 10 B.P. Adams, IV [1.1.1.1.1.6.7.2.2.1]
- 9 Edna Geraldine Adams [1.1.1.1.1.6.7.2.1]
- 8 Stanley Eugene Monroe, MD [1.1.1.1.1.6.7.3]
b. 31 Dec 1912 d. 30 Dec 2005
Minnie Eleanor Duncan b. 10 Aug 1919 d. 9 May 2016
- 9 Stanley Eugene Monroe, Jr [1.1.1.1.1.6.7.3.1]
b. 20 Feb 1944 d. 21 Jun 2011
- + J. Hill
C.L. Hudnall
- 10 J. Monroe [1.1.1.1.1.6.7.3.1.1]
- 10 J.H. Monroe [1.1.1.1.1.6.7.3.1.2]
- 10 J. Monroe [1.1.1.1.1.6.7.3.1.1]
- + J. Hill
- 9 A.D. Monroe [1.1.1.1.1.6.7.3.2]
- 9 R.M. Monroe [1.1.1.1.1.6.7.3.3]
- + N. Slaughter
H.J. Portman
- 10 C.A. Monroe [1.1.1.1.1.6.7.3.3.1]
- 10 C.A. Monroe [1.1.1.1.1.6.7.3.3.1]
- + N. Slaughter
- 9 K. Monroe [1.1.1.1.1.6.7.3.4]
J.Y. Buchanan
- 10 E.Y. Buchanan [1.1.1.1.1.6.7.3.4.1]
- 10 E.Y. Buchanan [1.1.1.1.1.6.7.3.4.1]
- 9 E. Monroe [1.1.1.1.1.6.7.3.5]
- + Woodard
T.J. Minor
- 10 Shannon Leigh Minor [1.1.1.1.1.6.7.3.5.1]
b. 20 Feb 1974 d. 7 Sep 1974
- 10 Shannon Leigh Minor [1.1.1.1.1.6.7.3.5.1]
- + Woodard
- 9 Stanley Eugene Monroe, Jr [1.1.1.1.1.6.7.3.1]
- 8 Howard Ulysess Monroe, MD [1.1.1.1.1.6.7.4]
b. 13 Jan 1917 d. 24 Apr 2002
- + Grace Irene Jenkins b. 3 Jan 1925 d. 27 Apr 1976
- + Grace Irene Jenkins b. 3 Jan 1925 d. 27 Apr 1976
- 8 Geraldine Monroe [1.1.1.1.1.6.7.5]
b. 4 Jul 1918 d. 29 Aug 2011
Andrew Nunan McCurry b. 4 Apr 1914 d. 16 May 1981
- 9 A.L. McCurry [1.1.1.1.1.6.7.5.1]
P. Wade
- 10 J. Wade [1.1.1.1.1.6.7.5.1.1]
- 10 J. Wade [1.1.1.1.1.6.7.5.1.1]
R.C. Black
- 10 K.A. Black [1.1.1.1.1.6.7.5.1.2]
- 10 K.A. Black [1.1.1.1.1.6.7.5.1.2]
- 9 M. McCurry [1.1.1.1.1.6.7.5.2]
Richard Ronald Reynolds b. 10 Apr 1945 d. 23 Nov 1995
- 10 R. Reynolds [1.1.1.1.1.6.7.5.2.1]
- + T. Lynn
- + T. Lynn
- 10 C. Reynolds [1.1.1.1.1.6.7.5.2.2]
- 10 R. Reynolds [1.1.1.1.1.6.7.5.2.1]
- 9 Mary Monroe McCurry [1.1.1.1.1.6.7.5.3]
b. 24 Oct 1951 d. 27 Aug 2011
- 9 A.L. McCurry [1.1.1.1.1.6.7.5.1]
- 8 Lance Truman Monroe, MD [1.1.1.1.1.6.7.1]
- 7 Emmett Harrison Monroe [1.1.1.1.1.6.8]
b. 9 Feb 1889 d. 2 Aug 1962
- 7 Nancy Ann Monroe [1.1.1.1.1.6.9]
b. 20 Mar 1892 d. 22 Apr 1916
Loran Ardee Bane b. 30 Aug 1888 d. 21 Oct 1969
- 8 Loren Edwin Bane [1.1.1.1.1.6.9.1]
b. 18 Feb 1914 d. 28 Dec 1994
Betty Lee McClammer b. 22 Jul 1922 d. 8 Apr 2001
- 9 S.L. Bane [1.1.1.1.1.6.9.1.1]
- + F. McLafferty
T.J. Corcoran
- 10 K.C. Corcoran [1.1.1.1.1.6.9.1.1.1]
- 10 K.C. Corcoran [1.1.1.1.1.6.9.1.1.1]
- + F. McLafferty
- 9 Edwin Lee Bane [1.1.1.1.1.6.9.1.2]
b. 24 Oct 1944 d. 2012
- 9 L.T. Bane [1.1.1.1.1.6.9.1.3]
- 9 L.L. Bane [1.1.1.1.1.6.9.1.4]
James Emerson Brady b. 22 Mar 1953 d. 27 Nov 2007
- 10 J.L. Brady [1.1.1.1.1.6.9.1.4.1]
- 10 J.L. Brady [1.1.1.1.1.6.9.1.4.1]
- 9 S.L. Bane [1.1.1.1.1.6.9.1.1]
- 8 Loren Edwin Bane [1.1.1.1.1.6.9.1]
- 7 Alfred Edwin Monroe, MD [1.1.1.1.1.6.1]
- 6 Tildon Howard Monroe [1.1.1.1.1.7]
b. Jul 1847 d. 8 Apr 1936
Malderene M Neil b. Apr 1852 d. 12 Apr 1927
- 7 Leona A Monroe [1.1.1.1.1.7.1]
b. 1868 d. 3 Mar 1923
- 7 Sam Melton Monroe [1.1.1.1.1.7.2]
b. 26 Dec 1868 d. 29 Mar 1956
Mary Elizabeth Evans, . b. 29 Mar 1865 d. 26 Nov 1940
- 8 Eddie Beecher Monroe [1.1.1.1.1.7.2.1]
b. 6 May 1888 d. 9 May 1961
- 8 Earon Homer Monroe [1.1.1.1.1.7.2.2]
b. 5 Nov 1890 d. 26 Nov 1971
Maude Chloe Akins b. 23 Jul 1893 d. 10 Nov 1960
- 9 Mildred Mae Monroe [1.1.1.1.1.7.2.2.1]
b. 26 Mar 1913 d. 9 Apr 2014
- + Virgle Monroe Barnes b. 28 Sep 1907 d. 7 Apr 1995
- + Virgle Monroe Barnes b. 28 Sep 1907 d. 7 Apr 1995
- 9 Ruby Lee Monroe [1.1.1.1.1.7.2.2.2]
b. 29 Sep 1914 d. 8 Dec 1990
- 9 James Milton Monroe [1.1.1.1.1.7.2.2.3]
b. 14 May 1917 d. 20 Sep 1970
Eunice Illene Stewart b. 11 Apr 1921 d. 4 Feb 1998
- 10 J.R. Monroe [1.1.1.1.1.7.2.2.3.1]
- 10 W.J. Monroe [1.1.1.1.1.7.2.2.3.2]
- 10 L.J. Monroe [1.1.1.1.1.7.2.2.3.3]
- 10 J.R. Monroe [1.1.1.1.1.7.2.2.3.1]
- 9 Earon Ruth Monroe [1.1.1.1.1.7.2.2.4]
b. 26 Mar 1919 d. 5 Mar 2006
Alton S Williams b. Abt 1916
- 10 A.H. Williams [1.1.1.1.1.7.2.2.4.1]
- 10 A.W. Williams [1.1.1.1.1.7.2.2.4.2]
- 10 P.E. Williams [1.1.1.1.1.7.2.2.4.3]
- 10 A.H. Williams [1.1.1.1.1.7.2.2.4.1]
- 9 Homer Weldon Monroe [1.1.1.1.1.7.2.2.5]
b. 25 Jul 1921 d. 3 May 2012
- 9 Charis Ardell Monroe [1.1.1.1.1.7.2.2.6]
b. 6 Sep 1923 d. 19 Nov 2007
Wanda Lucille Moser b. 4 Nov 1928 d. 6 Jan 2016
- 10 B.A. Monroe [1.1.1.1.1.7.2.2.6.1]
- 10 S.Y. Monroe [1.1.1.1.1.7.2.2.6.2]
- 10 Leonard Ardell Monroe [1.1.1.1.1.7.2.2.6.3]
b. 27 Sep 1958 d. 29 Jan 1960
- 10 B.A. Monroe [1.1.1.1.1.7.2.2.6.1]
- 9 R L Monroe [1.1.1.1.1.7.2.2.7]
b. Abt 1924 d. 3 May 2012
- 9 Veoma Maudine Monroe [1.1.1.1.1.7.2.2.8]
b. 3 Mar 1925 d. 17 Jun 2013
- + Elmer Lloyd Fisher b. 6 Dec 1924 d. 12 Jun 2004
- + Elmer Lloyd Fisher b. 6 Dec 1924 d. 12 Jun 2004
- 9 P.J. Monroe [1.1.1.1.1.7.2.2.9]
- 9 L.J. Monroe [1.1.1.1.1.7.2.2.10]
- 9 Patricia Ann Monroe [1.1.1.1.1.7.2.2.11]
b. 4 Nov 1939 d. 5 May 2021
- 9 Mildred Mae Monroe [1.1.1.1.1.7.2.2.1]
- 8 Lela Mae Monroe [1.1.1.1.1.7.2.3]
b. 15 Jun 1900 d. 13 Aug 1963
- 8 John T Monroe [1.1.1.1.1.7.2.4]
b. 7 Jun 1907 d. 27 Dec 1991
- 8 Eddie Beecher Monroe [1.1.1.1.1.7.2.1]
- 7 Nancy Monroe [1.1.1.1.1.7.3]
b. Abt 1871
- 7 McFarland F Monroe [1.1.1.1.1.7.4]
b. 26 Jul 1873 d. 7 Jul 1945
- 7 James Albert Clark Monroe [1.1.1.1.1.7.5]
b. 3 Oct 1873 d. 11 Nov 1964
- 7 Albert Monroe [1.1.1.1.1.7.6]
b. Oct 1876
- 7 David Edgar Monroe [1.1.1.1.1.7.7]
b. 22 Apr 1878 d. 26 Jun 1959
- 7 Martha Monroe [1.1.1.1.1.7.8]
b. 26 Apr 1884 d. 7 Aug 1955
- 7 George Emerson Monroe [1.1.1.1.1.7.9]
b. 16 May 1888 d. 4 Dec 1967
- 7 Owen Oscar Monroe [1.1.1.1.1.7.10]
b. 1 Aug 1889 d. 2 Jul 1966
- 7 Ruel L Monroe [1.1.1.1.1.7.11]
b. 27 Jun 1894 d. 25 Jul 1980
- 7 Myrtle Monroe [1.1.1.1.1.7.12]
b. Jul 1895
- 7 Leona A Monroe [1.1.1.1.1.7.1]
- 6 Woodson Taylor Monroe [1.1.1.1.1.8]
b. 13 Jan 1848 d. 30 Apr 1930
- 6 William George Monroe [1.1.1.1.1.9]
b. 1849 d. 1896
- 6 Lucinda Monroe [1.1.1.1.1.10]
b. 1853
- 6 Lee Anderson Monroe [1.1.1.1.1.11]
b. May 1854 d. 27 Jan 1924
- 6 Mark M Monroe [1.1.1.1.1.1]
- 5 Lucinda Monroe [1.1.1.1.2]
b. 27 Apr 1816 d. 14 Oct 1871
- 5 Calvin Monroe [1.1.1.1.3]
b. 22 May 1818 d. 7 Feb 1871
- 5 James L Monroe [1.1.1.1.4]
b. 30 Mar 1820
Margaret Bryan b. 1824 d. Aft 1870
- 6 Martha J Monroe [1.1.1.1.4.1]
b. 1843 d. Yes, date unknown
- 6 Hester Ann Monroe [1.1.1.1.4.2]
b. Abt 1844
- 6 Elvina Monroe [1.1.1.1.4.3]
b. Abt 1846
- 6 Alexander Monroe [1.1.1.1.4.4]
b. 19 Mar 1846 d. 29 Jul 1926
Martha Jane Miller b. 22 Apr 1845 d. 22 Apr 1920
- 7 August Kurvurul Monroe [1.1.1.1.4.4.1]
b. 21 Dec 1867 d. 21 Apr 1931
Annie Louise McDaniel b. 7 Jul 1872 d. 6 Feb 1968
- 8 Robert Steele Monroe [1.1.1.1.4.4.1.1]
b. 27 Sep 1893 d. 5 Jun 1969
- + Grace Dea Cramer b. 13 Nov 1898 d. 1985
- + Grace Dea Cramer b. 13 Nov 1898 d. 1985
- 8 Carrie Belle Grace Monroe [1.1.1.1.4.4.1.2]
b. 8 Oct 1897 d. 3 Feb 1987
August Brown Barnhouse b. 16 Jul 1890 d. 29 Nov 1965
- 9 Madeline Louise Barnhouse [1.1.1.1.4.4.1.2.1]
b. 16 Nov 1916 d. 31 Mar 1977
- 9 Norma Ruth Barnhouse [1.1.1.1.4.4.1.2.2]
b. 2 Sep 1920 d. 17 Jun 2011
Charles Arthur Crane b. 8 Nov 1917 d. 15 Nov 1992
- + James William Helms b. 10 Jan 1915 d. 25 Jun 1986
- 9 August Frederick Monroe Barnhouse [1.1.1.1.4.4.1.2.3]
b. 11 Jun 1922 d. 3 Mar 2009
Alpha Elizabeth Stephens b. 27 May 1922 d. 7 Nov 2006
- 10 D.E. Barnhouse [1.1.1.1.4.4.1.2.3.1]
N.W. Henley
- 11 L.E. Henley [1.1.1.1.4.4.1.2.3.1.1]
- 11 M.W. Henley [1.1.1.1.4.4.1.2.3.1.2]
- 11 L.E. Henley [1.1.1.1.4.4.1.2.3.1.1]
- 10 S.M. Barnhouse [1.1.1.1.4.4.1.2.3.2]
- 10 D.E. Barnhouse [1.1.1.1.4.4.1.2.3.1]
- 9 Madeline Louise Barnhouse [1.1.1.1.4.4.1.2.1]
- 8 Esther Monroe [1.1.1.1.4.4.1.3]
b. Abt 1903 d. Aug 1992
- 8 Arthur Barnes Monroe [1.1.1.1.4.4.1.4]
b. 13 Aug 1909 d. 17 Dec 1967
Harriet Lucille Fogle b. 11 Apr 1911 d. 30 Jun 1994
- 9 L.R. Monroe [1.1.1.1.4.4.1.4.1]
- 9 L.R. Monroe [1.1.1.1.4.4.1.4.1]
- 8 Robert Steele Monroe [1.1.1.1.4.4.1.1]
- 7 James Lycircus Monroe [1.1.1.1.4.4.2]
b. 22 May 1870 d. 2 Apr 1958
Eva Annetta Rice b. 27 Feb 1871 d. 1 Mar 1958
- 8 Cecil Augustus Monroe [1.1.1.1.4.4.2.1]
b. 21 Mar 1893 d. 22 Mar 1977
- + Elizabeth Rebecca Branson b. 27 Feb 1896 d. 19 Oct 1970
Rosa C Maasen b. 16 Mar 1895 d. 1 May 1966
- 9 Leona E Monroe [1.1.1.1.4.4.2.1.1]
b. 3 May 1915 d. 14 Oct 1993
- + E. Ott
John Edward Lynch b. 4 Feb 1918 d. 8 Sep 2001
- 10 John Wayne Lynch [1.1.1.1.4.4.2.1.1.1]
b. 30 Jul 1945 d. 2 Mar 2012
- 10 D.L. Lynch [1.1.1.1.4.4.2.1.1.2]
- + Austin
- + Austin
- 10 John Wayne Lynch [1.1.1.1.4.4.2.1.1.1]
- + E. Ott
- 9 Woodrow Fredrick Monroe [1.1.1.1.4.4.2.1.2]
b. 7 Nov 1916 d. 9 Oct 2004
Lioba Clara Kemper b. 29 Jun 1922 d. 30 May 1967
- 10 D.J. Monroe [1.1.1.1.4.4.2.1.2.1]
- 10 M.G. Monroe [1.1.1.1.4.4.2.1.2.2]
- 10 P.D. Monroe [1.1.1.1.4.4.2.1.2.3]
- 10 D.J. Monroe [1.1.1.1.4.4.2.1.2.1]
- + Lucinda A Nolting b. 10 May 1918 d. 12 Jan 2006
- 9 Leona E Monroe [1.1.1.1.4.4.2.1.1]
- + Elizabeth Rebecca Branson b. 27 Feb 1896 d. 19 Oct 1970
- 8 Cale Franklin Monroe [1.1.1.1.4.4.2.2]
b. 19 Sep 1894 d. 5 May 1971
- + Catherine Christina Richard b. 17 Feb 1895 d. 15 Nov 1990
- + Catherine Christina Richard b. 17 Feb 1895 d. 15 Nov 1990
- 8 Mary Monroe [1.1.1.1.4.4.2.3]
b. 13 Dec 1896 d. 13 Dec 1896
- 8 Clyde Joseph Monroe, Sr [1.1.1.1.4.4.2.4]
b. 19 Nov 1897 d. 26 Mar 1976
Estelle Elizabeth Barth b. 20 Aug 1912 d. 29 Jul 1957
- 9 Clyde Joseph Monroe, Jr [1.1.1.1.4.4.2.4.1]
b. 22 Jan 1937 d. 10 Oct 2005
M.Y. Von Dullen
- 10 Sherryl Lynn Monroe [1.1.1.1.4.4.2.4.1.1]
b. 22 Aug 1960 d. 27 Sep 2020
Michael David Hoover b. 18 Feb 1953 d. 20 Feb 2013
- 11 J.E. Hoover [1.1.1.1.4.4.2.4.1.1.1]
G. Duckworth
- 12 G. Duckworth [1.1.1.1.4.4.2.4.1.1.1.1]
- 12 S. Duckworth [1.1.1.1.4.4.2.4.1.1.1.2]
- 12 L. Duckworth [1.1.1.1.4.4.2.4.1.1.1.3]
- 12 G. Duckworth [1.1.1.1.4.4.2.4.1.1.1.1]
- 11 J.E. Hoover [1.1.1.1.4.4.2.4.1.1.1]
- 10 Christine Leslie Monroe [1.1.1.1.4.4.2.4.1.2]
b. 15 Aug 1962 d. 16 Jul 2019
G.W. Adams, III
- 11 W.C. Adams [1.1.1.1.4.4.2.4.1.2.1]
- + C. _____
- + C. _____
- 11 S.M. Adams [1.1.1.1.4.4.2.4.1.2.2]
- 11 W.C. Adams [1.1.1.1.4.4.2.4.1.2.1]
- 10 K.M. Monroe [1.1.1.1.4.4.2.4.1.3]
- + Mary Evelyn Rigsby b. 18 Apr 1948 d. 24 Feb 2019
- + Mary Evelyn Rigsby b. 18 Apr 1948 d. 24 Feb 2019
- 10 Sherryl Lynn Monroe [1.1.1.1.4.4.2.4.1.1]
- 9 Clyde Joseph Monroe, Jr [1.1.1.1.4.4.2.4.1]
- 8 Laverta Floy Monroe [1.1.1.1.4.4.2.5]
b. 25 Jul 1900 d. 21 Nov 1987
Anthony Villegas b. 17 Jan 1897 d. 21 Apr 1952
- 9 D. Villegas [1.1.1.1.4.4.2.5.1]
- 9 C. Villegas [1.1.1.1.4.4.2.5.2]
- 9 D. Villegas [1.1.1.1.4.4.2.5.1]
- 8 James Lafayette Monroe [1.1.1.1.4.4.2.6]
b. 8 Sep 1904 d. 22 Feb 1986
- 8 James Lon Monroe [1.1.1.1.4.4.2.7]
b. 1905 d. Bef 5 May 1971
- 8 Myrtle Faye Monroe [1.1.1.1.4.4.2.8]
b. 28 Feb 1905 d. 21 Feb 1950
Walter E Scott b. 3 Dec 1897 d. 22 Oct 1979
- 9 Olive Larue Scott [1.1.1.1.4.4.2.8.1]
b. 13 Aug 1923 d. 20 May 1999
Dallas M McKee b. 23 Apr 1922 d. 6 Oct 2005
- 10 C.D. McKee [1.1.1.1.4.4.2.8.1.1]
- 10 Teri Belinda McKee [1.1.1.1.4.4.2.8.1.2]
b. 22 Jul 1946 d. 25 Jan 1965
- 10 Toni Lalinda McKee [1.1.1.1.4.4.2.8.1.3]
b. 22 Jul 1946 d. 14 Jun 1991
- + Reece
- + Reece
- 10 C.D. McKee [1.1.1.1.4.4.2.8.1.1]
- 9 Jacquelyn Annette Scott [1.1.1.1.4.4.2.8.2]
b. 4 Jun 1925 d. 18 May 2008
Holland Edward Reece b. 9 Apr 1920 d. 3 Jun 1990
- 10 Hollis Ann Reece [1.1.1.1.4.4.2.8.2.1]
b. 3 Jul 1941 d. 12 Apr 2009
- 10 Scott Ashley Reece [1.1.1.1.4.4.2.8.2.2]
b. 20 Sep 1942 d. 28 Jul 2014
- 10 Nancy Adeline Reece [1.1.1.1.4.4.2.8.2.3]
b. 9 Jul 1943 d. 22 Feb 2021
- 10 Steven Edward Reece [1.1.1.1.4.4.2.8.2.4]
b. 31 Jul 1945 d. 24 Apr 2016
- 10 Stacey Dana Reece [1.1.1.1.4.4.2.8.2.5]
b. 7 May 1949 d. 28 Feb 1968
- 10 Kelly Faith Reece [1.1.1.1.4.4.2.8.2.6]
b. 31 Oct 1956 d. 6 Apr 2016
- 10 Hollis Ann Reece [1.1.1.1.4.4.2.8.2.1]
- 9 Leatha Joy Scott [1.1.1.1.4.4.2.8.3]
b. 16 Mar 1927 d. 29 Jul 1994
- + Leo J Zipp b. 9 Dec 1921 d. 27 Aug 2005
- + Leo J Zipp b. 9 Dec 1921 d. 27 Aug 2005
- 9 Waldean Maxie Scott [1.1.1.1.4.4.2.8.4]
b. 10 Aug 1928 d. 3 Mar 2005
Paul Glenwood Hurt b. 11 Aug 1922 d. 25 Jan 2003
- 10 Paula F Hurt [1.1.1.1.4.4.2.8.4.1]
b. 6 May 1948 d. 7 Feb 2009
- + Miller
- + Miller
- 10 Paula F Hurt [1.1.1.1.4.4.2.8.4.1]
- 9 James Monroe Scott [1.1.1.1.4.4.2.8.5]
b. 20 Jun 1931 d. 3 Jan 2002
- + Norma Louise Cowan b. 1925 d. 4 Jul 2012
- + Norma Louise Cowan b. 1925 d. 4 Jul 2012
- 9 Olive Larue Scott [1.1.1.1.4.4.2.8.1]
- 8 Loren G (Lon) Monroe [1.1.1.1.4.4.2.9]
b. 9 Jun 1906 d. 5 Dec 1966
- + Eula Carter Rainwater b. 2 May 1905 d. 21 Oct 1947
Mary Renee Ryan Montgomery b. 15 Sep 1927 d. 18 Jul 1983
- 9 L.L. Monroe [1.1.1.1.4.4.2.9.1]
- 9 L.L. Monroe [1.1.1.1.4.4.2.9.1]
- + Eula Carter Rainwater b. 2 May 1905 d. 21 Oct 1947
- 8 Lola Mae Monroe [1.1.1.1.4.4.2.10]
b. 15 Sep 1908 d. 15 Jun 2005
- 8 Allen Paul Monroe [1.1.1.1.4.4.2.11]
b. 18 Sep 1911 d. 14 Feb 1955
Edith Melvin Jacques b. 9 Apr 1911 d. 20 Nov 1998
- 9 L.A. Monroe [1.1.1.1.4.4.2.11.1]
- 9 L.A. Monroe [1.1.1.1.4.4.2.11.1]
- 8 Adline Fern Monroe [1.1.1.1.4.4.2.12]
b. 8 Dec 1920 d. 9 May 1997
- 8 Cecil Augustus Monroe [1.1.1.1.4.4.2.1]
- 7 Adam Aquilla Monroe [1.1.1.1.4.4.3]
b. 28 May 1872 d. 14 Jul 1949
Florence Lelien Patterson b. 29 Mar 1879 d. 18 Feb 1956
- 8 Frank J Monroe [1.1.1.1.4.4.3.1]
b. 26 Sep 1898 d. 2 Nov 1929
- 8 Mary Williams Monroe [1.1.1.1.4.4.3.2]
b. 25 Nov 1900 d. 26 Mar 1972
Edward Clinton Branson b. 20 Feb 1894 d. 22 Jul 1966
- 9 Grace Irene Branson [1.1.1.1.4.4.3.2.1]
b. 9 May 1918 d. 21 Feb 1988
Wade Oliver Thompson b. 13 Aug 1912 d. 9 Mar 1969
- 10 M. Thompson [1.1.1.1.4.4.3.2.1.1]
- 10 Melvyn O Thompson [1.1.1.1.4.4.3.2.1.2]
b. Abt 1939 d. 1940
- 10 M. Thompson [1.1.1.1.4.4.3.2.1.3]
- 10 M.O. Thompson [1.1.1.1.4.4.3.2.1.4]
- 10 M. Thompson [1.1.1.1.4.4.3.2.1.1]
- + Lee Roy Edgar Malan b. 5 Dec 1892 d. 9 Mar 1986
- 9 Velora Pearl Branson [1.1.1.1.4.4.3.2.2]
b. 7 Dec 1920 d. 14 Jan 1990
- 9 Erleen Juanita Branson [1.1.1.1.4.4.3.2.3]
b. 3 May 1923 d. 16 Jul 2004
Alfred August Schultz b. 30 Jun 1919 d. 19 Oct 1986
- 10 Alfred Eugene Schultz [1.1.1.1.4.4.3.2.3.1]
b. 8 Jul 1943 d. 25 Oct 1993
- 10 B.E. Schultz [1.1.1.1.4.4.3.2.3.2]
- 10 Alfred Eugene Schultz [1.1.1.1.4.4.3.2.3.1]
- 9 Omar Dallas Branson [1.1.1.1.4.4.3.2.4]
b. 26 Dec 1925 d. 15 Nov 2010
Virgil Willie Micke b. 17 Oct 1923 d. 19 Feb 1963
- 10 B.J. Micke [1.1.1.1.4.4.3.2.4.1]
- 10 B.J. Micke [1.1.1.1.4.4.3.2.4.1]
- + Franklin Delano Lansford b. 14 Nov 1936 d. 8 Oct 2009
- 9 Nadeen Branson [1.1.1.1.4.4.3.2.5]
b. 10 Mar 1929 d. 17 Dec 2008
- 9 Quilas Thomas Clinton Branson [1.1.1.1.4.4.3.2.6]
b. 27 Aug 1931 d. 23 Dec 2008
- 9 Mary Ellen Branson [1.1.1.1.4.4.3.2.7]
b. 27 Aug 1934 d. 16 Oct 1971
- 9 Janett Jerley Branson [1.1.1.1.4.4.3.2.8]
b. 13 Aug 1937 d. 28 May 2011
- + Ronald Charles Robertson b. 11 Apr 1934 d. 16 Dec 2009
- + Ronald Charles Robertson b. 11 Apr 1934 d. 16 Dec 2009
- 9 J.A. Branson [1.1.1.1.4.4.3.2.9]
- 9 Grace Irene Branson [1.1.1.1.4.4.3.2.1]
- 8 Myrtle Melissa Monroe [1.1.1.1.4.4.3.3]
b. 17 Feb 1904 d. 14 Mar 1968
Lee Roy Edgar Malan b. 5 Dec 1892 d. 9 Mar 1986
- 9 Bernis Adrian Malan [1.1.1.1.4.4.3.3.1]
b. 12 Mar 1922 d. 1 May 2003
- + Elsie Amanda Lange b. 16 Jan 1911 d. 31 May 2002
- + Elsie Amanda Lange b. 16 Jan 1911 d. 31 May 2002
- 9 Norma Lee Malan [1.1.1.1.4.4.3.3.2]
b. 26 Nov 1924 d. 27 Dec 2000
Chester R Helmig b. 11 Aug 1919 d. 22 Feb 1993
- 10 J.W. Helmig [1.1.1.1.4.4.3.3.2.1]
- 10 J.D. Helmig [1.1.1.1.4.4.3.3.2.2]
- 10 Jimmy Ray Helmig [1.1.1.1.4.4.3.3.2.3]
b. 7 Oct 1948 d. 16 Apr 1999
B.K. Hymes
- 11 J.H. Helmig [1.1.1.1.4.4.3.3.2.3.1]
- 11 A.M. Helmig [1.1.1.1.4.4.3.3.2.3.2]
- 11 J.H. Helmig [1.1.1.1.4.4.3.3.2.3.1]
- 10 J.W. Helmig [1.1.1.1.4.4.3.3.2.1]
- 9 Ruth Evelyn Malan [1.1.1.1.4.4.3.3.3]
b. 1 Sep 1927 d. 1 Mar 2013
Cullen Joseph Clingerman b. 15 Aug 1927 d. 5 Jan 1999
- 10 M. Clingerman [1.1.1.1.4.4.3.3.3.1]
- 10 C. Clingerman [1.1.1.1.4.4.3.3.3.2]
- 10 P. Clingerman [1.1.1.1.4.4.3.3.3.3]
- 10 M. Clingerman [1.1.1.1.4.4.3.3.3.1]
- 9 Robert Jennings Malan [1.1.1.1.4.4.3.3.4]
b. 2 May 1930 d. 31 Jan 2017
P.J. Whitehead
- 10 M. Malan [1.1.1.1.4.4.3.3.4.1]
- 10 William Lee Malan [1.1.1.1.4.4.3.3.4.2]
b. 19 Sep 1958 d. 26 Mar 2021
- + C.L. Luce
D.J. Kimball
- 11 C.L. Malan [1.1.1.1.4.4.3.3.4.2.1]
- 11 C.L. Malan [1.1.1.1.4.4.3.3.4.2.1]
T. Simpson
- 11 E. Malan [1.1.1.1.4.4.3.3.4.2.2]
- 11 E. Malan [1.1.1.1.4.4.3.3.4.2.2]
C. King
- 11 D. Malan [1.1.1.1.4.4.3.3.4.2.3]
- 11 D. Malan [1.1.1.1.4.4.3.3.4.2.3]
- + F. Welsh
- + C.L. Luce
- 10 M. Malan [1.1.1.1.4.4.3.3.4.1]
- 9 R.M. Malan [1.1.1.1.4.4.3.3.5]
- 9 P.M. Malon [1.1.1.1.4.4.3.3.6]
- 9 Bernis Adrian Malan [1.1.1.1.4.4.3.3.1]
- 8 Martha B (Mattie) Monroe [1.1.1.1.4.4.3.4]
b. 31 Oct 1908 d. 22 Oct 2000
Albert Anton (Bud) Baclesse, Sr b. 5 Jul 1902 d. 26 Apr 1988
- 9 A.M. Baclesse, Jr [1.1.1.1.4.4.3.4.1]
Melba Laverne Shockley b. 28 Oct 1928 d. 25 Jul 2019
- 10 T.O. Baclesse [1.1.1.1.4.4.3.4.1.1]
L.K. Davidson
- 11 C. Baclesse [1.1.1.1.4.4.3.4.1.1.1]
- + M. _____
- + M. _____
- 11 J.C. Baclesse [1.1.1.1.4.4.3.4.1.1.2]
- + S. _____
- + S. _____
- 11 C. Baclesse [1.1.1.1.4.4.3.4.1.1.1]
- 10 T.O. Baclesse [1.1.1.1.4.4.3.4.1.1]
- + B.L. Gibson
- 9 Janice Melba Baclesse [1.1.1.1.4.4.3.4.2]
b. 6 Feb 1931 d. 2 Apr 2018
Perry Edward (Smitty) Smith b. 10 Sep 1928 d. 5 Oct 2017
- 10 A. Smith [1.1.1.1.4.4.3.4.2.1]
- + K. Heckman
B.A. Green
- 11 T. Smith [1.1.1.1.4.4.3.4.2.1.1]
- 11 T. Smith [1.1.1.1.4.4.3.4.2.1.1]
- + K. Heckman
- 10 Vicky Lynn Smith [1.1.1.1.4.4.3.4.2.2]
b. 28 Mar 1950 d. 5 Jul 2021
C.E. Abbott, Jr
- 11 J. Abbott [1.1.1.1.4.4.3.4.2.2.1]
- 11 J. Abbott [1.1.1.1.4.4.3.4.2.2.2]
- 11 L.A. Abbott [1.1.1.1.4.4.3.4.2.2.3]
- 11 J. Abbott [1.1.1.1.4.4.3.4.2.2.1]
- + Wayne Nelson Ponder b. 17 Dec 1929 d. 30 Mar 2012
- 10 B.A. Smith [1.1.1.1.4.4.3.4.2.3]
E.J. Leivian, Jr
- 11 B. Leivian [1.1.1.1.4.4.3.4.2.3.1]
- 11 B. Leivian [1.1.1.1.4.4.3.4.2.3.1]
- 10 Kent (Smitty) Smith [1.1.1.1.4.4.3.4.2.4]
b. 3 Jun 1961 d. 22 Nov 2020
- 10 B. Smith [1.1.1.1.4.4.3.4.2.5]
- + D. _____
- + D. _____
- 10 G. Smith [1.1.1.1.4.4.3.4.2.6]
- + B. _____
- + B. _____
- 10 A. Smith [1.1.1.1.4.4.3.4.2.1]
- 9 Joy Lee Baclesse [1.1.1.1.4.4.3.4.3]
b. 24 Feb 1933 d. 3 Feb 2020
G.A. Niekamp
- 10 Richard Lee Baclesse [1.1.1.1.4.4.3.4.3.1]
b. 7 Sep 1958 d. 31 Jul 2013
- 10 Richard Lee Baclesse [1.1.1.1.4.4.3.4.3.1]
- 9 A.M. Baclesse, Jr [1.1.1.1.4.4.3.4.1]
- 8 Woodrow M Monroe [1.1.1.1.4.4.3.5]
b. 30 Nov 1912 d. 18 Feb 1975
- + Beula M Thomas b. Abt 1917
- + Beula M Thomas b. Abt 1917
- 8 Earl Aquilla Monroe [1.1.1.1.4.4.3.6]
b. 23 Sep 1915 d. 28 Aug 1987
Irene Virginia Branson b. 4 Mar 1921 d. 7 Aug 1990
- 9 Ronald Lee Monroe [1.1.1.1.4.4.3.6.1]
b. 14 Oct 1941 d. 2 May 1976
- 9 Shirley Mae Monroe [1.1.1.1.4.4.3.6.2]
b. 22 Apr 1943 d. 18 Jul 2011
- 9 S.K. Monroe [1.1.1.1.4.4.3.6.3]
- 9 Ronald Lee Monroe [1.1.1.1.4.4.3.6.1]
- + Mildred Huron Parker b. 19 Sep 1917 d. 5 Mar 2010
- 8 Howard Trenton (Tom) Monroe [1.1.1.1.4.4.3.7]
b. 29 Jan 1921 d. 11 Jun 1982
Mary Jane Wrest b. 1911 d. 1981
- 9 R.J. Monroe [1.1.1.1.4.4.3.7.1]
- 9 R.J. Monroe [1.1.1.1.4.4.3.7.1]
Neva Doreen Clark b. 12 Dec 1924 d. 23 Mar 2001
- 9 D.K. Monroe [1.1.1.1.4.4.3.7.2]
William Floyd Hudson, IV b. 17 Apr 1950 d. 27 Feb 2018
- 10 C.D. Hudson [1.1.1.1.4.4.3.7.2.1]
- 10 C.D. Hudson [1.1.1.1.4.4.3.7.2.1]
- 9 D.R. Monroe [1.1.1.1.4.4.3.7.3]
- + L. _____
- + L. _____
- 9 Virginia Mary Monroe [1.1.1.1.4.4.3.7.4]
b. 28 Feb 1951 d. 10 Jan 1984
- 9 Daniel Dwain Monroe [1.1.1.1.4.4.3.7.5]
b. 7 Jul 1953 d. 26 Jan 2008
- 9 D.K. Monroe [1.1.1.1.4.4.3.7.2]
- 8 Frank J Monroe [1.1.1.1.4.4.3.1]
- 7 Horace Maynard (Maine) Monroe [1.1.1.1.4.4.4]
b. 30 Jan 1875 d. 29 Apr 1956
Lucy Evelina Kerley b. 9 Sep 1883 d. 8 Aug 1965
- 8 William Benton Monroe [1.1.1.1.4.4.4.1]
b. 1 Feb 1904 d. 2 Jun 1982
Josephine Billie Branson b. 22 Mar 1918 d. 21 Jan 1994
- 9 Larry L Monroe [1.1.1.1.4.4.4.1.1]
b. 16 Mar 1939 d. 4 Jul 2021
- 9 L.L. Monroe [1.1.1.1.4.4.4.1.2]
- 9 Larry L Monroe [1.1.1.1.4.4.4.1.1]
- 8 Leroy A Monroe [1.1.1.1.4.4.4.2]
b. 10 Feb 1906 d. 19 Dec 1977
- 8 Raymond Oscar Monroe [1.1.1.1.4.4.4.3]
b. 19 Jun 1908 d. 13 Nov 1993
Ruth Hassler b. 1917 d. 27 Nov 1992
- 9 Y.A. Monroe [1.1.1.1.4.4.4.3.1]
- + Leigers
- + Leigers
- 9 Y.L. Monroe [1.1.1.1.4.4.4.3.2]
- 9 Robert Eugene Monroe [1.1.1.1.4.4.4.3.3]
b. 29 Aug 1936 d. 16 Feb 2000
- 9 Rosella T Monroe [1.1.1.1.4.4.4.3.4]
b. 21 Aug 1937 d. 19 Jan 1967
- 9 Y.A. Monroe [1.1.1.1.4.4.4.3.1]
- 8 Catherine Virginia Monroe [1.1.1.1.4.4.4.4]
b. 28 Jan 1911 d. 11 May 1997
Albert Baumgartner b. 1 Dec 1906 d. 17 Sep 1971
- 9 R. Baumgartner [1.1.1.1.4.4.4.4.1]
- 9 R. Baumgartner [1.1.1.1.4.4.4.4.1]
- + James Monroe Fink d. 1974
- 8 William Benton Monroe [1.1.1.1.4.4.4.1]
- 7 Addison Jones (Doc) Monroe [1.1.1.1.4.4.5]
b. 10 Oct 1877 d. 29 Jan 1928
Martha Ann (Mug) Smith b. 4 Apr 1882 d. 13 May 1965
- 8 Flossie Moneka Monroe [1.1.1.1.4.4.5.1]
b. 18 Mar 1900 d. 29 Apr 1980
William Clyde Curtit b. 21 Jan 1893 d. 14 Jan 1962
- 9 Maurine Ruth Curtit [1.1.1.1.4.4.5.1.1]
b. 10 Mar 1920 d. 15 Jun 1920
- 9 Connie Monroe Curtit [1.1.1.1.4.4.5.1.2]
b. 1 May 1921 d. 22 Nov 1965
Clara A Nilges b. 2 Sep 1923 d. 11 Feb 2002
- 10 Judith Ann Curtit [1.1.1.1.4.4.5.1.2.1]
b. 30 Sep 1941 d. 10 Mar 2006
- 10 J.W. Curtit [1.1.1.1.4.4.5.1.2.2]
- + B. _____
- + S.L. Faith
- + M.M. Strange
- + B. _____
- 10 Jerry Wayne Curtit [1.1.1.1.4.4.5.1.2.3]
b. 16 Feb 1947 d. 7 Jul 2015
- 10 S. Curtit [1.1.1.1.4.4.5.1.2.4]
- 10 Judith Ann Curtit [1.1.1.1.4.4.5.1.2.1]
- 9 Donald Robert Curtit, Sr [1.1.1.1.4.4.5.1.3]
b. 28 Aug 1923 d. 29 Aug 1973
Zelma Gunn b. 4 Dec 1923 d. 11 Mar 1994
- 10 D.R. Curtit, Jr [1.1.1.1.4.4.5.1.3.1]
- 10 Steven Arthur Curtit [1.1.1.1.4.4.5.1.3.2]
b. 11 Jan 1954 d. 9 Aug 1980
- 10 D.R. Curtit, Jr [1.1.1.1.4.4.5.1.3.1]
- 9 Billy Gene Curtit [1.1.1.1.4.4.5.1.4]
b. 7 Aug 1927 d. 22 Jul 1997
Margarette Louise (Dixie) Fowler b. 25 Jul 1928 d. 5 Apr 2012
- 10 M.K. Curtit [1.1.1.1.4.4.5.1.4.1]
- 10 J. Curtit [1.1.1.1.4.4.5.1.4.2]
- + D. Scott
- + D. Scott
- 10 J.L. Curtit [1.1.1.1.4.4.5.1.4.3]
- + R. Voss
- + L. Whiteside
D.L. Eiken
- 11 M.J. Eiken [1.1.1.1.4.4.5.1.4.3.1]
J.M. Jeffers
- 12 I. Eiken [1.1.1.1.4.4.5.1.4.3.1.1]
- 12 I. Eiken [1.1.1.1.4.4.5.1.4.3.1.1]
- 11 M.J. Eiken [1.1.1.1.4.4.5.1.4.3.1]
- + R. Voss
- 10 Samuel Clyde Curtit [1.1.1.1.4.4.5.1.4.4]
b. 7 Aug 1957 d. 7 Aug 1957
- 10 B.G. Curtit [1.1.1.1.4.4.5.1.4.5]
- 10 M.K. Curtit [1.1.1.1.4.4.5.1.4.1]
- 9 Maurine Ruth Curtit [1.1.1.1.4.4.5.1.1]
- 8 Nannie Vern Monroe [1.1.1.1.4.4.5.2]
b. 14 Feb 1902 d. 14 Sep 1970
George Thomas Kemple b. 4 Jul 1899 d. 5 Feb 1975
- 9 Floyd Glenn Kemple [1.1.1.1.4.4.5.2.1]
b. 1 Dec 1921 d. 20 Jan 1984
Mildred Ann Maasen b. 23 Oct 1927 d. 19 Apr 2012
- 10 A.J. Kemple [1.1.1.1.4.4.5.2.1.1]
B.J. Burd
- 11 J.A. Kemple [1.1.1.1.4.4.5.2.1.1.1]
- 11 J.A. Kemple [1.1.1.1.4.4.5.2.1.1.1]
E.M. Overkamp
- 11 E.A. Kemple [1.1.1.1.4.4.5.2.1.1.2]
- 11 R.G. Kemple [1.1.1.1.4.4.5.2.1.1.3]
- 11 E.A. Kemple [1.1.1.1.4.4.5.2.1.1.2]
- 10 Randall Lee Kemple [1.1.1.1.4.4.5.2.1.2]
b. 8 Dec 1952 d. 25 Oct 2019
S.L. Klatt
- 11 S.M. Kemple [1.1.1.1.4.4.5.2.1.2.1]
B. Berhorst
- 12 S. Berhorst [1.1.1.1.4.4.5.2.1.2.1.1]
- 12 C. Berhorst [1.1.1.1.4.4.5.2.1.2.1.2]
- 12 S. Berhorst [1.1.1.1.4.4.5.2.1.2.1.1]
- 11 B.N. Kemple [1.1.1.1.4.4.5.2.1.2.2]
- 11 J. Kemple [1.1.1.1.4.4.5.2.1.2.3]
- 11 S.M. Kemple [1.1.1.1.4.4.5.2.1.2.1]
- 10 R.W. Kemple [1.1.1.1.4.4.5.2.1.3]
N.N.F. (F28)
- 11 R.L. Kemple [1.1.1.1.4.4.5.2.1.3.1]
- 11 R.L. Kemple [1.1.1.1.4.4.5.2.1.3.1]
- 10 G.A. Kemple [1.1.1.1.4.4.5.2.1.4]
- + Schaefer
- + Rick Sundermeyer b. 7 Jan
- + Schaefer
- 10 A.J. Kemple [1.1.1.1.4.4.5.2.1.1]
- 9 Mary Louise Kemple [1.1.1.1.4.4.5.2.2]
b. 29 Mar 1924 d. 2 Jan 2006
Earl Joseph (E J) Banks, Jr b. 9 Aug 1923 d. 26 Jun 2011
- 10 L.G. Banks [1.1.1.1.4.4.5.2.2.1]
D.I. Redden
- 11 C.G. Banks [1.1.1.1.4.4.5.2.2.1.1]
S.A. Leach
- 12 H.A. Leach [1.1.1.1.4.4.5.2.2.1.1.1]
- 12 M.C. Leach [1.1.1.1.4.4.5.2.2.1.1.2]
- 12 H.A. Leach [1.1.1.1.4.4.5.2.2.1.1.1]
- 11 D.S. Banks [1.1.1.1.4.4.5.2.2.1.2]
T.L. Elliott
- 12 C.A. Newsome [1.1.1.1.4.4.5.2.2.1.2.1]
[ =>]
- 12 C.A. Newsome [1.1.1.1.4.4.5.2.2.1.2.2]
[ =>]
- 12 A.J. Banks [1.1.1.1.4.4.5.2.2.1.2.3]
- 12 A.L. Banks [1.1.1.1.4.4.5.2.2.1.2.4]
- 12 C.A. Newsome [1.1.1.1.4.4.5.2.2.1.2.1]
- 11 C.G. Banks [1.1.1.1.4.4.5.2.2.1.1]
- 10 Kenneth Lavern Banks [1.1.1.1.4.4.5.2.2.2]
b. 5 Oct 1949 d. 7 Jun 2012
Gwendolyn Irene Janes b. 4 Sep 1948 d. 24 May 2018
- 11 William Joseph Banks [1.1.1.1.4.4.5.2.2.2.1]
b. 30 Jul 1971 d. 25 Nov 2017
- 11 C.A. Banks [1.1.1.1.4.4.5.2.2.2.2]
W. Young, Sr
- 12 W. Young [1.1.1.1.4.4.5.2.2.2.2.1]
- 12 D. Young [1.1.1.1.4.4.5.2.2.2.2.2]
- 12 S.D. Young [1.1.1.1.4.4.5.2.2.2.2.3]
- 12 W. Young [1.1.1.1.4.4.5.2.2.2.2.1]
W.T. Wilson
- 12 Summer Nichole Banks [1.1.1.1.4.4.5.2.2.2.2.4]
b. 28 Feb 1992 d. 9 Oct 2013
- 12 Summer Nichole Banks [1.1.1.1.4.4.5.2.2.2.2.4]
N.N.F. (M28)
- 12 J.R. Banks [1.1.1.1.4.4.5.2.2.2.2.5]
- 12 J.R. Banks [1.1.1.1.4.4.5.2.2.2.2.5]
- 11 S.D. Banks [1.1.1.1.4.4.5.2.2.2.3]
I.L. Johnson, Jr
- 12 C.L. Johnson [1.1.1.1.4.4.5.2.2.2.3.1]
[ =>]
- 12 L. Johnson [1.1.1.1.4.4.5.2.2.2.3.2]
- 12 C.L. Johnson [1.1.1.1.4.4.5.2.2.2.3.1]
- 11 William Joseph Banks [1.1.1.1.4.4.5.2.2.2.1]
- + M.L. McAlister
J.K. Jordan
- 11 Z.R. Banks [1.1.1.1.4.4.5.2.2.2.4]
- 11 Z.R. Banks [1.1.1.1.4.4.5.2.2.2.4]
- 10 Lynda Ruth Banks [1.1.1.1.4.4.5.2.2.3]
b. 17 Jul 1951 d. 1 Jan 2017
Lonnie James (Shadtree) Butler b. 24 Jun 1950 d. 28 Nov 2007
- 11 T.J. Butler [1.1.1.1.4.4.5.2.2.3.1]
Tonia Regina Shockley b. 28 Nov 1966 d. 8 Dec 2013
- 12 L.J. Butler [1.1.1.1.4.4.5.2.2.3.1.1]
[ =>]
- 12 L.J. Butler [1.1.1.1.4.4.5.2.2.3.1.1]
- + F.R. Hammer
- 11 Michelle Lynn Butler [1.1.1.1.4.4.5.2.2.3.2]
b. 24 Oct 1970 d. 3 Jun 2004
C.M. Fizer
- 12 Shane Matthew Fizer [1.1.1.1.4.4.5.2.2.3.2.1]
b. 4 Aug 1988 d. 28 Mar 2005
- 12 Shane Matthew Fizer [1.1.1.1.4.4.5.2.2.3.2.1]
G.W. Wright
- 12 A.N. Fizer [1.1.1.1.4.4.5.2.2.3.2.2]
[ =>]
- 12 A.N. Fizer [1.1.1.1.4.4.5.2.2.3.2.2]
- 11 T.J. Butler [1.1.1.1.4.4.5.2.2.3.1]
- + T.W. Darling
Mark Edward Litton b. 14 Dec 1955 d. 2 Feb 2024
- 11 M.L. Litton [1.1.1.1.4.4.5.2.2.3.3]
- 11 M.L. Litton [1.1.1.1.4.4.5.2.2.3.3]
- + T.G. Jenkins
- 10 R.L. Banks [1.1.1.1.4.4.5.2.2.4]
K. Gentry
- 11 M.G. Spain [1.1.1.1.4.4.5.2.2.4.1]
- 11 S.R. Spain [1.1.1.1.4.4.5.2.2.4.2]
K. Milford
- 12 A. Milford [1.1.1.1.4.4.5.2.2.4.2.1]
- 12 A. Milford [1.1.1.1.4.4.5.2.2.4.2.1]
- 11 M.G. Spain [1.1.1.1.4.4.5.2.2.4.1]
F.A. Dautenhahn
- 11 J.J. Banks [1.1.1.1.4.4.5.2.2.4.3]
S.D. Kretschmer
- 12 L. Kretschmer [1.1.1.1.4.4.5.2.2.4.3.1]
- 12 H. Kretschmer [1.1.1.1.4.4.5.2.2.4.3.2]
- 12 C. Kretschmer [1.1.1.1.4.4.5.2.2.4.3.3]
- 12 L. Kretschmer [1.1.1.1.4.4.5.2.2.4.3.1]
- 11 A.C. Banks [1.1.1.1.4.4.5.2.2.4.4]
- 11 C.C. Banks [1.1.1.1.4.4.5.2.2.4.5]
- 11 J.J. Banks [1.1.1.1.4.4.5.2.2.4.3]
- + Q.K. Wilkes
- + L.L. Buhler
- 10 L.G. Banks [1.1.1.1.4.4.5.2.2.1]
- 9 Vivian Rea Kemple [1.1.1.1.4.4.5.2.3]
b. 26 Feb 1926 d. 25 Oct 2023
Milford Paul Spurgeon b. 4 Mar 1926 d. 20 May 2016
- 10 R.E. Spurgeon [1.1.1.1.4.4.5.2.3.1]
V.W. Hale
- 11 S.R. Spurgeon [1.1.1.1.4.4.5.2.3.1.1]
- 11 T.J. Spurgeon [1.1.1.1.4.4.5.2.3.1.2]
- + Tonia Regina Shockley b. 28 Nov 1966 d. 8 Dec 2013
- + Tonia Regina Shockley b. 28 Nov 1966 d. 8 Dec 2013
- 11 M.W. Spurgeon [1.1.1.1.4.4.5.2.3.1.3]
- 11 S.R. Spurgeon [1.1.1.1.4.4.5.2.3.1.1]
- 10 K.M. Spurgeon [1.1.1.1.4.4.5.2.3.2]
- + M. Patrick
- + E. Smith
Samuel Joseph Creek b. 9 Dec 1949 d. 17 Dec 2008
- 11 M.A. Creek [1.1.1.1.4.4.5.2.3.2.1]
J.W. Perkins
- 12 S.A. Perkins [1.1.1.1.4.4.5.2.3.2.1.1]
- 12 M.B. Perkins [1.1.1.1.4.4.5.2.3.2.1.2]
[ =>]
- 12 S.A. Perkins [1.1.1.1.4.4.5.2.3.2.1.1]
- 11 M.A. Creek [1.1.1.1.4.4.5.2.3.2.1]
- + M. Patrick
- 10 E.P. Spurgeon [1.1.1.1.4.4.5.2.3.3]
- + B. Sweer
M.J. Czeschin
- 11 A.N. Spurgeon [1.1.1.1.4.4.5.2.3.3.1]
- 11 A.N. Spurgeon [1.1.1.1.4.4.5.2.3.3.1]
- + B. Sweer
- 10 S.W. Spurgeon [1.1.1.1.4.4.5.2.3.4]
- + B.F. Briones
G.L. Niewald
- 11 E.K. Spurgeon [1.1.1.1.4.4.5.2.3.4.1]
- 11 E.K. Spurgeon [1.1.1.1.4.4.5.2.3.4.1]
- + B.F. Briones
- 10 B.K. Spurgeon [1.1.1.1.4.4.5.2.3.5]
Danny Ray Smith b. 13 Jan 1953 d. 12 Jul 2008
- 11 A.M. Smith [1.1.1.1.4.4.5.2.3.5.1]
- 11 T. Smith [1.1.1.1.4.4.5.2.3.5.2]
- + L. _____
- + L. _____
- 11 A.M. Smith [1.1.1.1.4.4.5.2.3.5.1]
- + J. Elrod
- 10 R.E. Spurgeon [1.1.1.1.4.4.5.2.3.1]
- 9 Marjorie Ruth Kemple [1.1.1.1.4.4.5.2.4]
b. 5 Nov 1930 d. 9 Apr 2014
Warren Alden Ridenhour b. 3 Aug 1921 d. 12 Dec 2005
- 10 Thomas Benton Ridenhour [1.1.1.1.4.4.5.2.4.1]
b. 27 May 1949 d. 16 Jan 1971
B.K. Phillips
- 11 T.K. Ridenhour [1.1.1.1.4.4.5.2.4.1.1]
K.P. Nilges
- 12 T.P. Nilges [1.1.1.1.4.4.5.2.4.1.1.1]
- 12 T.P. Nilges [1.1.1.1.4.4.5.2.4.1.1.1]
- 11 T.K. Ridenhour [1.1.1.1.4.4.5.2.4.1.1]
- 10 S.G. Ridenhour [1.1.1.1.4.4.5.2.4.2]
J.E. Crutsinger
- 11 C.E. Crutsinger [1.1.1.1.4.4.5.2.4.2.1]
- 11 C.E. Crutsinger [1.1.1.1.4.4.5.2.4.2.2]
- 11 C.E. Crutsinger [1.1.1.1.4.4.5.2.4.2.1]
- 10 T.R. Ridenhour [1.1.1.1.4.4.5.2.4.3]
- + R.C. Bartle
C.D. Ridenhour
- 11 T.B. Ridenhour [1.1.1.1.4.4.5.2.4.3.1]
- 11 S.M. Ridenhour [1.1.1.1.4.4.5.2.4.3.2]
- 11 T.B. Ridenhour [1.1.1.1.4.4.5.2.4.3.1]
- + R.C. Bartle
- 10 Thomas Benton Ridenhour [1.1.1.1.4.4.5.2.4.1]
- 9 N.L. Kemple [1.1.1.1.4.4.5.2.5]
- 9 Virginia Kay Kemple [1.1.1.1.4.4.5.2.6]
b. 9 Dec 1943 d. 28 Jul 2021
David Leslie Gilpin b. 29 Mar 1939 d. 23 May 2006
- 10 D.L. Gilpin [1.1.1.1.4.4.5.2.6.1]
P. Gilpin
- 11 D.D. Gilpin [1.1.1.1.4.4.5.2.6.1.1]
- 11 D.D. Gilpin [1.1.1.1.4.4.5.2.6.1.1]
- 10 J.D. Gilpin [1.1.1.1.4.4.5.2.6.2]
- 10 S.K. Gilpin [1.1.1.1.4.4.5.2.6.3]
R. Colter
- 11 R.D. Colter [1.1.1.1.4.4.5.2.6.3.1]
- 11 Z.D. Colter [1.1.1.1.4.4.5.2.6.3.2]
- 11 R.D. Colter [1.1.1.1.4.4.5.2.6.3.1]
S. Rohlfing
- 11 A.B. Rohlfing [1.1.1.1.4.4.5.2.6.3.3]
- 11 A.B. Rohlfing [1.1.1.1.4.4.5.2.6.3.3]
N.N.F. (M07)
- 11 K.R. _____ [1.1.1.1.4.4.5.2.6.3.4]
R. Shelton
- 12 L. Shelton [1.1.1.1.4.4.5.2.6.3.4.1]
- 12 S. Shelton [1.1.1.1.4.4.5.2.6.3.4.2]
- 12 R.E.L. Shelton [1.1.1.1.4.4.5.2.6.3.4.3]
- 12 L. Shelton [1.1.1.1.4.4.5.2.6.3.4.1]
- 11 M.D. Berry [1.1.1.1.4.4.5.2.6.3.5]
- 11 K.R. _____ [1.1.1.1.4.4.5.2.6.3.4]
- 10 D.L. Gilpin [1.1.1.1.4.4.5.2.6.1]
- 9 Carol Ann Kemple [1.1.1.1.4.4.5.2.7]
b. 10 Oct 1946 d. 1 Mar 2016
- + Clarence Dean Bowers b. 15 Nov 1945 d. 4 Jul 1991
Robert Lee Heemeier b. 25 Jul 1946 d. 6 Oct 2000
- 10 D.A. Heemeier [1.1.1.1.4.4.5.2.7.1]
- 10 D.L. Heemeier [1.1.1.1.4.4.5.2.7.2]
- 10 D.A. Heemeier [1.1.1.1.4.4.5.2.7.1]
L.J. Moore
- 10 Melissa Eileen Moore [1.1.1.1.4.4.5.2.7.3]
b. 21 Nov 1971 d. 12 Feb 2019
G. Brown
- 11 J. Moore [1.1.1.1.4.4.5.2.7.3.1]
N.N.F. (F49)
- 12 R.J. Moore [1.1.1.1.4.4.5.2.7.3.1.1]
- 12 R.J. Moore [1.1.1.1.4.4.5.2.7.3.1.1]
- 11 C. Brown [1.1.1.1.4.4.5.2.7.3.2]
- 11 J. Moore [1.1.1.1.4.4.5.2.7.3.1]
- 10 Melissa Eileen Moore [1.1.1.1.4.4.5.2.7.3]
- + D.T. Green
- + Richard Glen Meeks, Jr b. 7 Nov 1948 d. 8 Feb 2009
- + Clarence Dean Bowers b. 15 Nov 1945 d. 4 Jul 1991
- 9 Floyd Glenn Kemple [1.1.1.1.4.4.5.2.1]
- 8 Robert Steele Monroe [1.1.1.1.4.4.5.3]
b. 18 Jun 1905 d. 24 Jan 1957
Martha Opal (Mattie) Bacon b. 16 Nov 1906 d. 10 Mar 1998
- 9 Robert Bacon Monroe [1.1.1.1.4.4.5.3.1]
b. 25 Mar 1927 d. 15 Jan 1937
- 9 Robert Bacon Monroe [1.1.1.1.4.4.5.3.1]
Viola Edith Leach b. 28 Jun 1912 d. 20 Jun 2000
- 9 Michael Edward Monroe [1.1.1.1.4.4.5.3.2]
b. 22 Jan 1944 d. 26 Jul 1944
- 9 Marsha Gay Monroe [1.1.1.1.4.4.5.3.3]
b. 14 Jul 1946 d. 24 Sep 1968
- + R.L. Hill
- + Charles Olivar Angell b. 30 Nov 1944 d. 9 Feb 2006
- + R.L. Hill
- 9 Michael Edward Monroe [1.1.1.1.4.4.5.3.2]
- 8 Maude Grace Monroe [1.1.1.1.4.4.5.4]
b. 9 Jan 1908 d. Feb 1982
Leonard Lonzo Eastham b. 21 Jan 1901 d. 6 Dec 1986
- 9 Lonnie Lee Eastham [1.1.1.1.4.4.5.4.1]
b. 27 Aug 1928 d. 14 Sep 2016
M.D. Howell
- 10 M.L. Eastham [1.1.1.1.4.4.5.4.1.1]
- 10 M.L. Eastham [1.1.1.1.4.4.5.4.1.1]
- 9 Patrica Ann Eastham [1.1.1.1.4.4.5.4.2]
b. 26 Oct 1934 d. 7 Mar 2017
J. Elder
- 10 L.E. Elder [1.1.1.1.4.4.5.4.2.1]
- 10 L.E. Elder [1.1.1.1.4.4.5.4.2.1]
W.C. Ponder
- 10 M.C. Ponder [1.1.1.1.4.4.5.4.2.2]
- 10 S.L. Ponder [1.1.1.1.4.4.5.4.2.3]
- 10 E.L. Ponder [1.1.1.1.4.4.5.4.2.4]
Brenda Ann Bolin d. Aft 1996
- 11 R. Ponder [1.1.1.1.4.4.5.4.2.4.1]
- 11 Aaron Jacob Ponder [1.1.1.1.4.4.5.4.2.4.2]
b. 5 Sep 1989 d. 25 Oct 2018
N.N.F. (F57)
- 12 E.E. Ponder [1.1.1.1.4.4.5.4.2.4.2.1]
- 12 E.E. Ponder [1.1.1.1.4.4.5.4.2.4.2.1]
- 11 R. Ponder [1.1.1.1.4.4.5.4.2.4.1]
- 10 M.C. Ponder [1.1.1.1.4.4.5.4.2.2]
Leonard Lee Neal b. 14 Dec 1931 d. 26 Apr 1995
- 10 K.G. Neal [1.1.1.1.4.4.5.4.2.5]
- 10 K.G. Neal [1.1.1.1.4.4.5.4.2.5]
- 9 R. Eastham [1.1.1.1.4.4.5.4.3]
U. Henn
- 10 J. Eastham [1.1.1.1.4.4.5.4.3.1]
- 10 G.L. Eastham [1.1.1.1.4.4.5.4.3.2]
- 10 R.H. Eastham [1.1.1.1.4.4.5.4.3.3]
- 10 J. Eastham [1.1.1.1.4.4.5.4.3.1]
- 9 Lonnie Lee Eastham [1.1.1.1.4.4.5.4.1]
- 8 Ruth Nellie Monroe [1.1.1.1.4.4.5.5]
b. 17 Jul 1910 d. 2 Sep 1996
- + William John Lammert b. 1 Sep 1904 d. 29 Jun 1974
- + William John Lammert b. 1 Sep 1904 d. 29 Jun 1974
- 8 Ester Marie Monroe [1.1.1.1.4.4.5.6]
b. 21 Sep 1914 d. 1 Mar 1987
Hugo Peter Kemmer b. 18 Dec 1911 d. 19 Apr 2001
- 9 J.H. Kemmer [1.1.1.1.4.4.5.6.1]
- + L. _____
J. Wade
- 10 J. Kemmer [1.1.1.1.4.4.5.6.1.1]
- 10 Spencer James Kemmer [1.1.1.1.4.4.5.6.1.2]
b. 20 Dec 1968 d. 30 May 2017
- 10 K.K. Kemmer [1.1.1.1.4.4.5.6.1.3]
- 10 J. Kemmer [1.1.1.1.4.4.5.6.1.1]
- + V.J. Elliott
- + L. _____
- 9 Sandra Jean Kemmer [1.1.1.1.4.4.5.6.2]
b. 26 May 1939 d. 25 Apr 2021
John William Herndon b. 18 Jan 1938 d. 20 May 2016
- 10 K.J. Herndon [1.1.1.1.4.4.5.6.2.1]
- 10 C.A. Herndon [1.1.1.1.4.4.5.6.2.2]
- 10 S.L. Herndon [1.1.1.1.4.4.5.6.2.3]
- 10 K.J. Herndon [1.1.1.1.4.4.5.6.2.1]
- 9 Jane Rea Kemmer [1.1.1.1.4.4.5.6.3]
b. 11 Jan 1943 d. 8 Aug 2016
Ronald E Scheel b. 23 Jan 1940 d. 17 Aug 2022
- 10 L.A. Scheel [1.1.1.1.4.4.5.6.3.1]
Gary Wayne Dendy b. 5 Feb 1954 d. 9 Oct 2017
- 11 N.W. Dendy [1.1.1.1.4.4.5.6.3.1.1]
- 11 N.J. Dendy [1.1.1.1.4.4.5.6.3.1.2]
- 11 N.W. Dendy [1.1.1.1.4.4.5.6.3.1.1]
- 10 J.S. Scheel [1.1.1.1.4.4.5.6.3.2]
C.J. McMurray
- 11 W.R. Scheel [1.1.1.1.4.4.5.6.3.2.1]
- 11 W.R. Scheel [1.1.1.1.4.4.5.6.3.2.1]
- 10 L.A. Scheel [1.1.1.1.4.4.5.6.3.1]
- + Craig Lee Davis b. Abt 1938 d. 30 Apr 2013
- 9 J.A. Kemmer [1.1.1.1.4.4.5.6.4]
- + Leo Herman (Stu) Hueste, Jr b. 2 Jun 1943 d. 28 Dec 2006
- + Leo Herman (Stu) Hueste, Jr b. 2 Jun 1943 d. 28 Dec 2006
- 9 J.H. Kemmer [1.1.1.1.4.4.5.6.1]
- 8 Harry Edward Monroe [1.1.1.1.4.4.5.7]
b. 4 Nov 1921 d. 29 Aug 2004
Louvenia Mae (Vengie) McKenzie b. 30 Jul 1923 d. 30 Apr 2018
- 9 J.R. Monroe [1.1.1.1.4.4.5.7.1]
- + S. _____
- + S. _____
- 9 James Von Monroe [1.1.1.1.4.4.5.7.2]
b. 13 May 1961 d. 29 Sep 2022
- 9 J.R. Monroe [1.1.1.1.4.4.5.7.1]
- 8 Flossie Moneka Monroe [1.1.1.1.4.4.5.1]
- 7 Louis Edward Monroe [1.1.1.1.4.4.6]
b. 2 Jun 1880 d. 31 Jan 1965
- 7 Marcus J Monroe [1.1.1.1.4.4.7]
b. 30 Jul 1884 d. 13 Oct 1970
Sophia Ellen Branson b. 24 Mar 1889 d. 19 May 1990
- 8 Cora Ellen Monroe [1.1.1.1.4.4.7.1]
b. 16 Dec 1909 d. 7 Sep 1911
- 8 William Reed Monroe [1.1.1.1.4.4.7.2]
b. 14 Sep 1911 d. 4 Nov 1998
Mildred Lucille Evans b. 12 Jun 1917 d. 12 Mar 1998
- 9 J. Monroe [1.1.1.1.4.4.7.2.1]
- 9 Lillian Ruth Monroe [1.1.1.1.4.4.7.2.2]
b. 11 Feb 1935 d. 30 Jan 2017
- + John Francis Nilges b. 14 Nov 1934 d. 16 Aug 1963
- + K.J. Gove
- + John Francis Nilges b. 14 Nov 1934 d. 16 Aug 1963
- 9 E.R. Monroe [1.1.1.1.4.4.7.2.3]
- + Wanda Lee Swoboda b. 4 Sep 1939 d. 6 Nov 2019
- + Wanda Lee Swoboda b. 4 Sep 1939 d. 6 Nov 2019
- 9 Charles Paul Monroe [1.1.1.1.4.4.7.2.4]
b. 15 Feb 1945 d. 5 Aug 2019
R.J. Brandt
- 10 A. Monroe [1.1.1.1.4.4.7.2.4.1]
- 10 J. Monroe [1.1.1.1.4.4.7.2.4.2]
N. Lansford
- 11 A. Lansford [1.1.1.1.4.4.7.2.4.2.1]
- 11 C. Lansford [1.1.1.1.4.4.7.2.4.2.2]
- 11 A. Lansford [1.1.1.1.4.4.7.2.4.2.1]
- 10 M.L. Monroe [1.1.1.1.4.4.7.2.4.3]
- 10 C.S. Monroe [1.1.1.1.4.4.7.2.4.4]
- 10 A. Monroe [1.1.1.1.4.4.7.2.4.1]
- 9 J. Monroe [1.1.1.1.4.4.7.2.1]
- 8 Elsie Hazel Monroe [1.1.1.1.4.4.7.3]
b. 31 Oct 1914 d. 15 May 2005
Charles Parrish Callis b. 5 Sep 1915 d. 15 Apr 1995
- 9 M.L. Callis [1.1.1.1.4.4.7.3.1]
- + D. Buie
- + D. Buie
- 9 M.L. Callis [1.1.1.1.4.4.7.3.1]
- 8 Mabel Lucille Monroe [1.1.1.1.4.4.7.4]
b. 10 Sep 1916 d. 5 Nov 2009
- + R. Coons
Earl Elijah Johnson b. 5 Dec 1920 d. 15 May 1988
- 9 C. Johnson [1.1.1.1.4.4.7.4.1]
- 9 C. Johnson [1.1.1.1.4.4.7.4.1]
- + R. Coons
- 8 Mary Ellen Monroe [1.1.1.1.4.4.7.5]
b. 1918 d. Bef 15 May 2005
- 8 Alvin (Corkey) Monroe [1.1.1.1.4.4.7.6]
b. 1 May 1921 d. 15 May 2005
Edna Imogene Moseley b. 5 Jun 1927 d. 4 Nov 2018
- 9 K. Monroe [1.1.1.1.4.4.7.6.1]
- 9 Angelee Monroe [1.1.1.1.4.4.7.6.2]
b. 9 Jul 1946 d. 9 Jul 1946
- 9 Judy Ann Monroe [1.1.1.1.4.4.7.6.3]
b. 7 May 1947 d. 5 Feb 2016
D.J. Schaefer
- 10 D.J. Schaefer, II [1.1.1.1.4.4.7.6.3.1]
- 10 L. Schaefer [1.1.1.1.4.4.7.6.3.2]
- 10 A. Schaefer [1.1.1.1.4.4.7.6.3.3]
- 10 D.J. Schaefer, II [1.1.1.1.4.4.7.6.3.1]
- 9 J.D. Monroe [1.1.1.1.4.4.7.6.4]
- 9 M. Monroe [1.1.1.1.4.4.7.6.5]
- 9 K. Monroe [1.1.1.1.4.4.7.6.1]
- 8 Lorene Monroe [1.1.1.1.4.4.7.7]
b. 12 Nov 1929 d. 24 May 2015
Phillips Doyle Worrell b. 26 Apr 1926 d. 26 Feb 1998
- 9 G.L. Worrell [1.1.1.1.4.4.7.7.1]
- 9 G.L. Worrell [1.1.1.1.4.4.7.7.1]
- 8 Cora Ellen Monroe [1.1.1.1.4.4.7.1]
- 7 August Kurvurul Monroe [1.1.1.1.4.4.1]
- 6 Elizabeth Monroe [1.1.1.1.4.5]
b. Abt 1848
- 6 James Monroe [1.1.1.1.4.6]
b. Abt 1851
- 6 Loretta Monroe [1.1.1.1.4.7]
b. Abt 1852
- 6 Margaret Monroe [1.1.1.1.4.8]
b. Abt 1859
- 6 Martha J Monroe [1.1.1.1.4.1]
- 5 Cyrenia Monroe [1.1.1.1.5]
b. 3 Jan 1822
N.N.F. (M25)
- 6 Noah Monroe [1.1.1.1.5.1]
b. 12 Jun 1837
- 6 Noah Monroe [1.1.1.1.5.1]
- + Charles O Warwick b. 1823
- 5 Orleania Monroe [1.1.1.1.6]
b. 5 Sep 1823 d. 8 Nov 1849
- 5 Vilania Jane Monroe [1.1.1.1.7]
b. 5 Jul 1825 d. 4 May 1850
- 5 Isaac John Monroe [1.1.1.1.8]
b. 1 Sep 1827 d. 21 Mar 1892
- 5 Mary Nervy Monroe [1.1.1.1.9]
b. 1 Apr 1831 d. 21 Mar 1891
- 5 Almanda Louise Monroe [1.1.1.1.10]
b. 1 Aug 1833 d. 13 Apr 1900
John Pennington Warwick b. 8 Mar 1835 d. 2 Jan 1895
- 6 Caroline Warwick [1.1.1.1.10.1]
b. 1855
- 6 Elvin M Warwick [1.1.1.1.10.2]
b. 28 Mar 1857 d. 13 Aug 1938
- 6 Alexander Z Warwick [1.1.1.1.10.3]
b. 24 Mar 1858 d. 31 Oct 1940
- + Mary Francis Griffin b. 4 Oct 1861 d. 7 Jan 1946
- + Mary Francis Griffin b. 4 Oct 1861 d. 7 Jan 1946
- 6 Elizabeth Betty Warwick [1.1.1.1.10.4]
b. 9 Jan 1861 d. 1 Oct 1881
- 6 Elijah L Warwick [1.1.1.1.10.5]
b. 4 Oct 1863 d. 6 Jan 1933
- 6 Detrus Monroe Warwick [1.1.1.1.10.6]
b. Oct 1865 d. 19 Jan 1951
- 6 William Albert Warwick [1.1.1.1.10.7]
b. Jun 1869 d. 14 Jun 1936
- 6 John L Warwick [1.1.1.1.10.8]
b. 1873
- 6 Caroline Warwick [1.1.1.1.10.1]
- 5 Elizabeth Sarah Monroe [1.1.1.1.11]
b. 25 Mar 1836 d. 25 Mar 1901
- 5 William George Monroe [1.1.1.1.12]
b. 25 Mar 1836 d. 2 Oct 1907
Adeline Atkins b. 30 May 1848 d. 3 Aug 1895
- 6 Horace Maynard Monroe [1.1.1.1.12.1]
b. 8 Sep 1861 d. 11 Dec 1936
Luzana Elizabeth Graves b. 5 Sep 1865 d. 3 Jan 1890
- 7 Ariebell Monroe [1.1.1.1.12.1.1]
b. 18 Jul 1885 d. 12 Jul 1966
- 7 William Preston Monroe [1.1.1.1.12.1.2]
b. 20 Nov 1886 d. 17 Oct 1940
Callie Isabelle Edmondson b. Abt 1891 d. 25 Jun 1964
- 8 Harmon Lawrence Monroe [1.1.1.1.12.1.2.1]
b. 9 Sep 1909 d. 11 Mar 1991
- 8 Walter Preston Monroe [1.1.1.1.12.1.2.2]
b. 30 May 1911 d. 25 Apr 1967
Vada E Lynch b. 1 Jul 1911 d. 23 Dec 1993
- 9 E. Monroe [1.1.1.1.12.1.2.2.1]
- 9 L.D. Monroe [1.1.1.1.12.1.2.2.2]
- 9 Charles Preston Monroe [1.1.1.1.12.1.2.2.3]
b. 7 Dec 1934 d. 7 Jul 1941
- 9 E. Monroe [1.1.1.1.12.1.2.2.1]
- 8 Vada Etta Lynch [1.1.1.1.12.1.2.3]
b. 1 Jul 1911 d. 15 Dec 1993
Walter Preston Monroe b. 30 May 1911 d. 25 Apr 1967
- 9 Leon D Monroe [1.1.1.1.12.1.2.3.1]
b. Feb 1932 d. 12 Aug 2019
- 9 Charles Preston Monroe [1.1.1.1.12.1.2.3.2]
b. 7 Dec 1934 d. 7 Jul 1941
- 9 Leon D Monroe [1.1.1.1.12.1.2.3.1]
- 8 Irby Horace Monroe [1.1.1.1.12.1.2.4]
b. 7 Nov 1912 d. 11 Mar 1991
- 8 Jesse A Monroe [1.1.1.1.12.1.2.5]
b. 13 Apr 1914 d. 29 Jan 1994
- 8 Harmon Lawrence Monroe [1.1.1.1.12.1.2.1]
- 7 Richard Sylvester Monroe, MD [1.1.1.1.12.1.3]
b. 6 Dec 1888 d. 6 Jan 1954
Ella Jane Ousley b. 26 Jun 1892 d. 18 Oct 1977
- 8 Leah Elizabeth Monroe [1.1.1.1.12.1.3.1]
b. 12 Oct 1914 d. 16 Dec 1981
William C Wolfe b. Abt 1908 d. Yes, date unknown
- 9 J.E. Wolfe [1.1.1.1.12.1.3.1.1]
- 9 J.E. Wolfe [1.1.1.1.12.1.3.1.1]
- 8 Eileen Monroe [1.1.1.1.12.1.3.2]
b. Abt 1917
- 8 Vauda Lee Monroe [1.1.1.1.12.1.3.3]
b. 14 Jun 1919 d. 30 Oct 2011
Charles H Needham b. 24 Jun 1920 d. 16 Aug 1993
- 9 D.C. Needham [1.1.1.1.12.1.3.3.1]
- 9 L.L. Needham [1.1.1.1.12.1.3.3.2]
- 9 D.C. Needham [1.1.1.1.12.1.3.3.1]
- 8 Leah Elizabeth Monroe [1.1.1.1.12.1.3.1]
- 7 Ariebell Monroe [1.1.1.1.12.1.1]
Mary J Gilbert b. 22 Jan 1871 d. 26 May 1939
- 7 Vadie Monroe [1.1.1.1.12.1.4]
b. Mar 1891 d. 23 Nov 1974
- 7 Iva Monroe [1.1.1.1.12.1.5]
b. Sep 1892
- 7 George Monroe [1.1.1.1.12.1.6]
b. 7 Nov 1893 d. Abt 1956
Pauline Victoria Birkenmeyer b. 13 May 1900 d. 12 Oct 1973
- 8 Harold J Monroe [1.1.1.1.12.1.6.1]
b. 6 Aug 1927 d. 31 Jul 1999
- 8 K.P. Monroe [1.1.1.1.12.1.6.2]
- 8 M.M. Monroe [1.1.1.1.12.1.6.3]
- 8 Harold J Monroe [1.1.1.1.12.1.6.1]
- 7 James Monroe [1.1.1.1.12.1.7]
b. May 1895 d. 30 Dec 1968
- 7 Horace Oda Monroe [1.1.1.1.12.1.8]
b. 9 Jan 1898 d. 21 Mar 1978
Della Maude Sharp b. 28 Jan 1903 d. 22 Aug 1983
- 8 Naomi Monroe [1.1.1.1.12.1.8.1]
b. 13 Feb 1919 d. 9 Dec 2009
Richard Pettiebone Campbell, Jr b. 26 Oct 1914 d. 29 May 1995
- 9 R.G. Campbell [1.1.1.1.12.1.8.1.1]
- 9 Gloria Faye Campbell [1.1.1.1.12.1.8.1.2]
b. 4 Feb 1942 d. 22 Jan 2014
- 9 J. Campbell [1.1.1.1.12.1.8.1.3]
- 9 R. Campbell [1.1.1.1.12.1.8.1.4]
- 9 R.G. Campbell [1.1.1.1.12.1.8.1.1]
- 8 Roy Parks Monroe [1.1.1.1.12.1.8.2]
b. 23 Apr 1920 d. 14 May 1996
- 8 Sarah Frances Monroe [1.1.1.1.12.1.8.3]
b. 16 Mar 1928 d. 31 Aug 2017
- 8 Naomi Monroe [1.1.1.1.12.1.8.1]
- 7 Biddie Monroe [1.1.1.1.12.1.9]
b. 23 Jun 1907 d. 24 Jul 1983
- + Wyrick
- + Wyrick
- 7 Ica Scates Monroe [1.1.1.1.12.1.10]
b. 23 Jun 1907 d. 1 Apr 1951
Coy E Sharp b. 1909 d. 1975
- 7 Vadie Monroe [1.1.1.1.12.1.4]
- 6 Mary Etter Monroe [1.1.1.1.12.2]
b. 21 Feb 1868 d. 26 Feb 1926
- 6 Elizabeth Monroe [1.1.1.1.12.3]
b. 25 Feb 1870 d. 25 Mar 1901
- 6 Eugene Dodge Monroe [1.1.1.1.12.4]
b. 27 Apr 1872 d. 8 Oct 1937
- 6 Minnie Warren Monroe [1.1.1.1.12.5]
b. 2 Aug 1874 d. 13 Dec 1972
- 6 James L Monroe [1.1.1.1.12.6]
b. 23 Jun 1877 d. 23 Sep 1936
- 6 Lillian L Monroe [1.1.1.1.12.7]
b. 30 Sep 1880 d. 12 May 1973
- 6 Robert Thornburgh Monroe [1.1.1.1.12.8]
b. 29 Mar 1884 d. Nov 1929
Bertha L Butcher b. 1886
- 7 Cleda Alpha Monroe [1.1.1.1.12.8.1]
b. 9 Feb 1907 d. 14 Mar 1995
- 7 Claude La Vaughn Monroe [1.1.1.1.12.8.2]
b. 11 Jul 1909
- 7 Cleda Alpha Monroe [1.1.1.1.12.8.1]
- 6 Alice Monroe [1.1.1.1.12.9]
b. 25 Jan 1887 d. 24 Jan 1888
- 6 Milton Tecumseh Monroe [1.1.1.1.12.10]
b. 18 Apr 1889 d. 13 Aug 1946
- 6 Horace Maynard Monroe [1.1.1.1.12.1]
- 5 John F Monroe [1.1.1.1.13]
b. 27 Jun 1839
Ruth Jane Turner b. 6 Dec 1840 d. 12 May 1880
- 6 Nancy Morlena Monroe [1.1.1.1.13.1]
b. Sep 1858 d. 3 Jan 1905
- 6 Alexander L Monroe [1.1.1.1.13.2]
b. 2 Feb 1861 d. 26 Apr 1948
- 6 Jacob B Monroe [1.1.1.1.13.3]
b. Abt 1864 d. 6 Dec 1948
- 6 Nancy Morlena Monroe [1.1.1.1.13.1]
- 5 Lea Anderson Monroe [1.1.1.1.1]
- 4 Magdalene Davis [1.1.1.2]
b. 1805
- 4 Llewellyn Anderson Davis [1.1.1.3]
b. 1810
- 4 Isaac Davis, Jr [1.1.1.4]
b. 11 May 1810 d. 1873
- 4 Nancy Davis [1.1.1.1]
- 3 Isaac Davis [1.1.1]
- 2 Elizabeth Pritchard [1.1]